DELTA FLUID PRODUCTS LIMITED

DELTA FLUID PRODUCTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDELTA FLUID PRODUCTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04279520
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DELTA FLUID PRODUCTS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe DELTA FLUID PRODUCTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Crane House Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Suffolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DELTA FLUID PRODUCTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HAMSARD 2376 LIMITED31 août 200131 août 2001

    Quels sont les derniers comptes de DELTA FLUID PRODUCTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour DELTA FLUID PRODUCTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 01 nov. 2023

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c and capital redemption reserve 31/10/2023
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 18 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Christopher Gray en tant qu'administrateur le 03 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Clive Tuck en tant que directeur le 03 avr. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Mark Royston Hopes en tant que directeur le 31 mars 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jason Charles Locke en tant qu'administrateur le 23 mars 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de DELTA FLUID PRODUCTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LOCKE, Jason Charles
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    Secrétaire
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    201413890001
    GRAY, Christopher
    100 First Stamford Place
    CT 06902 Stamford
    Crane Company
    United States
    Administrateur
    100 First Stamford Place
    CT 06902 Stamford
    Crane Company
    United States
    United KingdomBritish307661110001
    LOCKE, Jason Charles
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    Administrateur
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    EnglandBritish281244640001
    BURR, Stephen Mark
    176 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    176 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    British76697560001
    CANSDALE, Paul
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    Secrétaire
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    168042160001
    HOBBS, Steven John, Mr.
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    Secrétaire
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    157485720001
    LUMSDEN, Judith Ann
    Robins
    Lindsey Tye
    IP7 6PP Ipswich
    Secrétaire
    Robins
    Lindsey Tye
    IP7 6PP Ipswich
    British120706720001
    WILSON, Peter Rowland
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    Secrétaire
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    164343410001
    HSE SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secrétaire
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580006
    BURR, Stephen Mark
    176 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    176 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish76697560001
    COOPER, Steven
    4 Lincoln Close
    Hartshead
    OL6 8BS Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Administrateur
    4 Lincoln Close
    Hartshead
    OL6 8BS Ashton Under Lyne
    Lancashire
    British82314410001
    CURRAN, Garrett John
    128 Delaware Mansions
    Delaware Road
    W9 2LL London
    Administrateur
    128 Delaware Mansions
    Delaware Road
    W9 2LL London
    Irish81719790001
    FINNEGAN, Gerard Charles
    Medlar Cottage Folly Lane
    Copdock
    IP8 3JQ Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Medlar Cottage Folly Lane
    Copdock
    IP8 3JQ Ipswich
    Suffolk
    United KingdomIrish97686480001
    HOPES, Mark Royston
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    Administrateur
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    EnglandBritish150588610001
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Administrateur
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    British118771650001
    LUMSDEN, Judith Ann
    Robins
    Lindsey Tye
    IP7 6PP Ipswich
    Administrateur
    Robins
    Lindsey Tye
    IP7 6PP Ipswich
    EnglandBritish120706720001
    PYE, David Michael
    Ffordd Maenan
    Eglwysbach
    LL28 5UG Colwyn Bay
    Bryn Derw
    Clwyd
    United Kingdom
    Administrateur
    Ffordd Maenan
    Eglwysbach
    LL28 5UG Colwyn Bay
    Bryn Derw
    Clwyd
    United Kingdom
    WalesBritish82455850003
    TRAVIS, Brian Thomas
    Colts Hey Farm
    Alt Hill Lane
    OL6 8AP Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Administrateur
    Colts Hey Farm
    Alt Hill Lane
    OL6 8AP Ashton Under Lyne
    Lancashire
    United KingdomBritish82171230002
    TUCK, Richard Clive
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    Administrateur
    Epsilon Terrace
    West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    Suffolk
    EnglandBritish223644440001
    WILSON, Peter George
    Coles Oak House Coles Oak Lane
    CO7 6DN Dedham
    Essex
    Administrateur
    Coles Oak House Coles Oak Lane
    CO7 6DN Dedham
    Essex
    EnglandBritish37238690004
    HSE DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    England
    Administrateur
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    England
    73774730002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DELTA FLUID PRODUCTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Crane Limited
    Epsilon Terrace, West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    England
    06 avr. 2016
    Epsilon Terrace, West Road
    IP3 9FJ Ipswich
    Crane House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistered In England And Wales
    Numéro d'enregistrement00098677
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    DELTA FLUID PRODUCTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Chattel mortgage
    Créé le 20 févr. 2007
    Livré le 21 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Mori seiki hitech vertical turning centre s/no CSY20035. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transactions
    • 21 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 janv. 2007
    Livré le 10 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Chattel mortgage
    Créé le 28 avr. 2006
    Livré le 05 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on ay account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    1 DB0066 doug booth tumbler type shotblast plant dce uma 252 dust collector unit s/no 164.932, 1 DB0266 and DB0479 inductotherm 125R power trak 2 x 50KG brass capacity lift-out crucible furnace, DB0236 and DV0480 inductotherm 125 2 x 50KG brass capacity lift-out crucible furnace for details of further chattels charged please refer to form 395 all its plant and machinery assigns by way of security the policies. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 05 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 juil. 2004
    Livré le 24 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Créé le 09 févr. 2004
    Livré le 26 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 26 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 29 janv. 2004
    Livré le 14 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £189,039.50 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The sum of £189,039.50 as contained in the rent deposit deed dated 29 january 2004.
    Personnes ayant droit
    • Delta Road St Helens LLP
    Transactions
    • 14 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 24 sept. 2002
    Livré le 26 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Policy no CII005878798 over life of brian thomas travis for £500,000.00,expiry date 25/4/2009 with all sums,bonuses and benefits thereunder and all right,title and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Close Securities Limited
    Transactions
    • 26 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 09 juil. 2002
    Livré le 10 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All sums assured and all bonuses and benefits arising under the policy on the life of stephen mark burr with bupa health assurance limited policy number H126153501/CT15/001 for cover of £250,000.
    Personnes ayant droit
    • Close Securities Limited
    Transactions
    • 10 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 10 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due from the company,formerly known as hamsard 2376 limited,to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/Hold land and buildings lying to the north of bramwell street; t/no la 180464.
    Personnes ayant droit
    • Delta Industries Limited
    Transactions
    • 10 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 10 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due from the company,formerly known as hamsard 2376 limited,to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/Hold property known as 560-562 (even) at 4 chorlton st,stretford rd,old trafford,gt.manchester; gm 355824.
    Personnes ayant droit
    • Delta Industries Limited
    Transactions
    • 10 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 10 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due from the company,formerly known as hamsard 2376 limited,to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Including f/hold land and buildings known as 560-562 and 4 chorlton st,stretford rd,old trafford,gt.manchester; t/nos gm 355824 and la 323825. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Delta Industries Limited
    Transactions
    • 10 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 10 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due from the company,formerly known as hamsard 2376 limited,to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/Hold property known as 560-562 (even nos) at 4 chorlton st,stretford rd,old trafford,gt.manchester; la 323825.
    Personnes ayant droit
    • Delta Industries Limited
    Transactions
    • 10 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 10 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due from the company,formerly known as hamsard 2376 limited,to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/Hold property known as land and buildings lying to the north of bramwell street; la 180463.
    Personnes ayant droit
    • Delta Industries Limited
    Transactions
    • 10 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 01 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as hamsard 2376 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all and every interest in or over the f/h property known as land and buildings to the north of bramwell street t/n LA180463 which the company now or at any time after the date of the charge has power to charge and the proceeds of sale of the property all moneys to be received under any policy of insurance effected in respect of the property by way of floating charge the company's assets and the proceeds of sale of the company's assets.
    Personnes ayant droit
    • Close Securities Limited
    Transactions
    • 01 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 01 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as hamsard 2376 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all and every interest in or over the f/h property known as 560-562 and 4 chorlton street, stretford road, old trafford, greater manchester t/n LA323825 which the company now or at any time after the date of the charge has power to charge and the proceeds of sale of the property all moneys to be received under any policy of insurance effected in respect of the property by way of floating charge the company's assets and the proceeds of sale of the company's assets.
    Personnes ayant droit
    • Close Securities Limited
    Transactions
    • 01 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 01 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as hamsard 2376 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all and every interest in or over the f/h property known as land and buildings lying to the north of bramwell street, merseyside-st. Helens t/n LA180464 which the company now or at any time after the date of the charge has power to charge and the proceeds of sale of the property all moneys to be received under any policy of insurance effected in respect of the property by way of floating charge the company's assets and the proceeds of sale of the company's assets.
    Personnes ayant droit
    • Close Securities Limited
    Transactions
    • 01 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 01 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as hamsard 2376 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all and every interest in or over the f/h property known as land and buildings lying to the north side of stretford road, old trafford, greater manchester t/n GM355824 which the company now or at any time after the date of the charge has power to charge and the proceeds of sale of the property all moneys to be received under any policy of insurance effected in respect of the property by way of floating charge the company's assets and the proceeds of sale of the company's assets.
    Personnes ayant droit
    • Close Securities Limited
    Transactions
    • 01 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 01 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as hamsard 2376 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (A)the f/h land and buildings known as 4 chorlton street and 560-562 stretford road, old trafford, greater manchester t/n's GM355824 and LA323825 (b) the f/h land and buildings being the entire site lying to the north of bramwell street t/n's LA180463 and LA180464. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Securities Limited
    Transactions
    • 01 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0