EHA PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEHA PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04280128
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EHA PROPERTIES LIMITED ?

    • Construction de bâtiments commerciaux (41201) / Construction

    Où se situe EHA PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o CG&CO
    17 St. Anns Square
    M2 7PW Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EHA PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SPEED 8906 LIMITED03 sept. 200103 sept. 2001

    Quels sont les derniers comptes de EHA PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EHA PROPERTIES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour EHA PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 sept. 2014

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 déc. 2014

    État du capital au 30 déc. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Dionne Mills en tant que secrétaire le 09 juil. 2014

    2 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Chandos House Oak Green Business Park Earl Road Cheadle Hulme Cheshire SK8 6QL à 17 St. Anns Square Manchester M2 7PW le 28 juil. 2014

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Keith Phillip Gannon en tant que directeur le 09 juil. 2014

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Nazzari Di Calabiana Willan en tant qu'administrateur le 08 juil. 2014

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 sept. 2013

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juil. 2014

    État du capital au 28 juil. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2013

    3 pagesAA

    Demande de rétablissement administratif

    3 pagesRT01

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Brian Corcoran en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2012

    3 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 sept. 2012

    État du capital après une attribution d'actions au 30 sept. 2012

    SH01

    Nomination de Mr Keith Phillip Gannon en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Sumner en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Brian Christopher Corcoran en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Dionne Mills en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de , 73 Liverpool Road, Crosby, Liverpool, Merseyside, L23 5SE à Chandos House Oak Green Business Park Earl Road Cheadle Hulme Cheshire SK8 6QL le 22 août 2012

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Clare Sumner en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    2 pagesLQ02

    Qui sont les dirigeants de EHA PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLAN, Paul Nazzari Di Calabiana
    1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Gregs Building
    Administrateur
    1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Gregs Building
    EnglandItalian152428400001
    ALLINGHAM, Christopher Patrick
    6 Mill Grove Path
    BT47 3YU Eglinton
    Derry
    Secrétaire
    6 Mill Grove Path
    BT47 3YU Eglinton
    Derry
    British104623060001
    MILLS, Dionne
    Oak Green Business Park
    Earl Road
    SK8 6QL Cheadle Hulme
    Chandos House
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Oak Green Business Park
    Earl Road
    SK8 6QL Cheadle Hulme
    Chandos House
    Cheshire
    England
    British171560220001
    SUMNER, Clare Margaret
    73 Liverpool Road
    L23 5SE Crosby
    Ground Floor
    Merseyside
    United Kingdom
    Secrétaire
    73 Liverpool Road
    L23 5SE Crosby
    Ground Floor
    Merseyside
    United Kingdom
    Other133786220001
    SUMNER, John Gerald
    6 Stanneybrook Close
    WA6 8PZ Norley
    Cheshire
    Secrétaire
    6 Stanneybrook Close
    WA6 8PZ Norley
    Cheshire
    British70404250002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ALLINGHAM, Edward Herrick
    41 Whitehill Road
    BT47 3JT Eglinton
    County Derry
    Northern Ireland
    Administrateur
    41 Whitehill Road
    BT47 3JT Eglinton
    County Derry
    Northern Ireland
    Northern IrelandUnited Kingdom143054000001
    BROWN, Colin Edward
    17 Beechfield Road
    L18 3EG Liverpool
    Administrateur
    17 Beechfield Road
    L18 3EG Liverpool
    British49404210001
    CORCORAN, Brian Christopher
    Oak Green Business Park
    Earl Road
    SK8 6QL Cheadle Hulme
    Chandos House
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Oak Green Business Park
    Earl Road
    SK8 6QL Cheadle Hulme
    Chandos House
    Cheshire
    England
    EnglandBritish43888360002
    GANNON, Keith Phillip
    Oak Green Business Park
    Earl Road
    SK8 6QL Cheadle Hulme
    Chandos House
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Oak Green Business Park
    Earl Road
    SK8 6QL Cheadle Hulme
    Chandos House
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish95548640003
    SUMNER, Clare Margaret
    1 Regents Field, Victoria Road
    Formby
    L37 1YX Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    1 Regents Field, Victoria Road
    Formby
    L37 1YX Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish124667920001
    SUMNER, John Gerald
    6 Stanneybrook Close
    WA6 8PZ Norley
    Cheshire
    Administrateur
    6 Stanneybrook Close
    WA6 8PZ Norley
    Cheshire
    United KingdomBritish70404250002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    EHA PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 28 juin 2012
    Livré le 05 juil. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and £340,000 due or to become due from the borrower to maddox developments limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H parcel of land being land on the south side of chatham place, liverpool, t/no: MS447299 together with all buildings and fixtures (inncluding tarde and tenants fixtures belonging to it) see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Michael Brown and Allan Brown (A Security Trustee)
    Transactions
    • 05 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal mortgage
    Créé le 17 janv. 2007
    Livré le 25 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land on the south side of chatham place liverpool t/no MS447299. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 25 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 116 mai 2012Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 107 juil. 2012Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
    • 13 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
      • Numéro de dossier 1
    Legal charge
    Créé le 28 avr. 2004
    Livré le 10 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company or by thamesbrook (liverpool) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h land with t/no MS447299 being land on the south side of chatham place li. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 10 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over all book debts
    Créé le 05 févr. 2003
    Livré le 19 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 19 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge
    Créé le 05 févr. 2003
    Livré le 19 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 19 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    EHA PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lyn L Vardy
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    receiver manager
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Toby Scott Underwood
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    receiver manager
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0