RED FUNNEL FERRIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRED FUNNEL FERRIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04281782
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GREENSOURCE LIMITED05 sept. 200105 sept. 2001

    Quels sont les derniers comptes de RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Notification de Falcon Acquisitions Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018

    2 pagesPSC02

    Cessation de Red Funnel Group (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018

    1 pagesPSC07

    Notification de Red Funnel Group (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018

    2 pagesPSC02

    Cessation de Red Funnel Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018

    1 pagesPSC07

    Satisfaction de la charge 042817820005 en totalité

    1 pagesMR04

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 31 janv. 2018

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Edward Arthur Wilson en tant que directeur le 08 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Francis Campbell en tant que directeur le 08 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charles John Gore Hazelwood en tant que directeur le 08 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jonathan Mark Moorhouse Green en tant que directeur le 11 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Arthur Murray Carter en tant que directeur le 11 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Mark Slawson en tant que directeur le 11 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Wallace Inch en tant que directeur le 12 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lee Richard Hudson en tant que directeur le 12 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Shirley Ann Anderson en tant que directeur le 13 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 042817820004 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 07 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 042817820005, créée le 20 juil. 2017

    17 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GEORGE, Kevin Alan
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish186130710001
    WINTER, Paul Richard
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish132752850001
    HUME, Kate
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    Secrétaire
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    British78063700002
    MILES, Graham John
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Secrétaire
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    British8125620001
    SHEARD, John Paul
    42 Serpentine Road
    PO16 7EB Fareham
    Hampshire
    Secrétaire
    42 Serpentine Road
    PO16 7EB Fareham
    Hampshire
    British61554710001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDERSON, Shirley Ann
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish254667910001
    BLAND, Christopher Donald Jack
    Yafford House
    PO30 3LH Shorwell
    Isle Of Wight
    Administrateur
    Yafford House
    PO30 3LH Shorwell
    Isle Of Wight
    United KingdomBritish8125610001
    BRADBURY, Kenton Edward
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish147513860001
    CAMPBELL, Michael Francis
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    CanadaCanadian235365510001
    CARTER, Arthur Murray
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish127391460001
    COOPER, James Nigel Shelley
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish265561970001
    DELLACHA, Maria Georgina
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish174489750001
    DOCHERTY, Thomas James
    Garden Cottage
    Fritham Court Fritham
    SO43 7HH Lyndhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Garden Cottage
    Fritham Court Fritham
    SO43 7HH Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritish83269560002
    DOMINY, Jacqueline
    Woodlands 46 Telegraph Road
    West End
    SO30 3EX Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Woodlands 46 Telegraph Road
    West End
    SO30 3EX Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish206004200001
    EDWARDS, Keith David William
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish114681720002
    FULFORD, James Simon Richard
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish137465940001
    GLASS, Olive Helen
    55 Ashdale Park
    RG40 3QS Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    55 Ashdale Park
    RG40 3QS Wokingham
    Berkshire
    British38249750003
    GORDON, Gavin James
    Flat 8 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7ER London
    Administrateur
    Flat 8 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7ER London
    British90600880001
    GREEN, Jonathan Mark Moorhouse
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish127407610001
    HAZELWOOD, Charles John Gore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish111535480002
    HELMORE, Max David Charles
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish174349030001
    HETHERINGTON, Colin Crawford
    Woodpeckers
    64 Baring Road
    PO31 8DJ Cowes
    Isle Of Wight
    Administrateur
    Woodpeckers
    64 Baring Road
    PO31 8DJ Cowes
    Isle Of Wight
    British103607280004
    HUDSON, Lee Richard
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish156861680001
    INCH, John Wallace
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish222917320001
    MILES, Graham John
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    British8125620001
    NELSON, Stephen Keith James
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish91708030001
    RAYNER, William John
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish99969530001
    SCHUMACHER, Bernd
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandGerman169583030001
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish107002130001
    SLAWSON, James Mark
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish191539160001
    WHYTE, Alistair Morrison
    11 Stoney Lane
    SO22 6DN Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    11 Stoney Lane
    SO22 6DN Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish8125600001
    WILSON, Edward Arthur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Administrateur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish214718430001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Red Funnel Group (Holdings) Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    31 janv. 2018
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement05115188
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Falcon Acquisitions Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    31 janv. 2018
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement06238324
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Red Funnel Group Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    06 avr. 2016
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementUk Company Register
    Numéro d'enregistrement03968658
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    RED FUNNEL FERRIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 juil. 2017
    Livré le 27 juil. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All land (except for restricted land) as listed in schedule 1 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery at any time thereon, intellectual property (except for any restricted ip), and the specified intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the deed of accession and charge registered by this form MR01.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbc Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 27 juil. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 08 juil. 2016
    Livré le 12 juil. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transactions
    • 12 juil. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 25 oct. 2007
    Livré le 01 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 01 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Red funnel deed of charge
    Créé le 21 déc. 2001
    Livré le 02 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings being k/a the red funnel ferry terminal car parks and car marshalling areas east cowes isle of wight t/nos IW49024, IW49023, IW49041, IW42695, IW29058 all f/h land and buildings at fountain quay west cowes t/no IW49025 f/h land and buldings at 10,12,14 and 16 bugle street southampton t/no HP596087 (for full details of all property charged see form 395) together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of New York (For Itself and on Behalf of the Other Red Funnel Secured Parties) (the "Security Trustee")
    Transactions
    • 02 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 oct. 2001
    Livré le 26 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present or future obligations of the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents and the mezzanine finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 26 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0