RED FUNNEL FERRIES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RED FUNNEL FERRIES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04281782 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Notification de Falcon Acquisitions Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Red Funnel Group (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contr ôle significatif le 31 janv. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Notification de Red Funnel Group (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Red Funnel Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 042817820005 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 31 janv. 2018
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Edward Arthur Wilson en tant que directeur le 08 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Francis Campbell en tant que directeur le 08 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charles John Gore Hazelwood en tant que directeur le 08 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 14 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Mark Moorhouse Green en tant que directeur le 11 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Arthur Murray Carter en tant que directeur le 11 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Mark Slawson en tant que directeur le 11 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Wallace Inch en tant que directeur le 12 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lee Richard Hudson en tant que directeur le 12 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Shirley Ann Anderson en tant que directeur le 13 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 042817820004 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 août 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Inscription de la charge 042817820005, créée le 20 juil. 2017 | 17 pages | MR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGE, Kevin Alan | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 186130710001 | |||||
| WINTER, Paul Richard | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 132752850001 | |||||
| HUME, Kate | Secrétaire | Broadwalk House 5 Appold Street EC2A 2HA London | British | 78063700002 | ||||||
| MILES, Graham John | Secrétaire | Willow Lodge Sway Road SO42 7SG Brockenhurst Hampshire | British | 8125620001 | ||||||
| SHEARD, John Paul | Secrétaire | 42 Serpentine Road PO16 7EB Fareham Hampshire | British | 61554710001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ANDERSON, Shirley Ann | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 254667910001 | |||||
| BLAND, Christopher Donald Jack | Administrateur | Yafford House PO30 3LH Shorwell Isle Of Wight | United Kingdom | British | 8125610001 | |||||
| BRADBURY, Kenton Edward | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 147513860001 | |||||
| CAMPBELL, Michael Francis | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | Canada | Canadian | 235365510001 | |||||
| CARTER, Arthur Murray | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 127391460001 | |||||
| COOPER, James Nigel Shelley | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 265561970001 | |||||
| DELLACHA, Maria Georgina | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 174489750001 | |||||
| DOCHERTY, Thomas James | Administrateur | Garden Cottage Fritham Court Fritham SO43 7HH Lyndhurst Hampshire | England | British | 83269560002 | |||||
| DOMINY, Jacqueline | Administrateur | Woodlands 46 Telegraph Road West End SO30 3EX Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 206004200001 | |||||
| EDWARDS, Keith David William | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 114681720002 | |||||
| FULFORD, James Simon Richard | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 137465940001 | |||||
| GLASS, Olive Helen | Administrateur | 55 Ashdale Park RG40 3QS Wokingham Berkshire | British | 38249750003 | ||||||
| GORDON, Gavin James | Administrateur | Flat 8 The Design Works 93-99 Goswell Road EC1V 7ER London | British | 90600880001 | ||||||
| GREEN, Jonathan Mark Moorhouse | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 127407610001 | |||||
| HAZELWOOD, Charles John Gore | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 111535480002 | |||||
| HELMORE, Max David Charles | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 174349030001 | |||||
| HETHERINGTON, Colin Crawford | Administrateur | Woodpeckers 64 Baring Road PO31 8DJ Cowes Isle Of Wight | British | 103607280004 | ||||||
| HUDSON, Lee Richard | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 156861680001 | |||||
| INCH, John Wallace | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 222917320001 | |||||
| MILES, Graham John | Administrateur | Willow Lodge Sway Road SO42 7SG Brockenhurst Hampshire | British | 8125620001 | ||||||
| NELSON, Stephen Keith James | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 91708030001 | |||||
| RAYNER, William John | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 99969530001 | |||||
| SCHUMACHER, Bernd | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | German | 169583030001 | |||||
| SCOTT, Richard Antony Cargill | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 107002130001 | |||||
| SLAWSON, James Mark | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 191539160001 | |||||
| WHYTE, Alistair Morrison | Administrateur | 11 Stoney Lane SO22 6DN Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 8125600001 | |||||
| WILSON, Edward Arthur | Administrateur | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 214718430001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RED FUNNEL FERRIES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Funnel Group (Holdings) Limited | 31 janv. 2018 | Bugle Street SO14 2JY Southampton 12 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Falcon Acquisitions Limited | 31 janv. 2018 | Bugle Street SO14 2JY Southampton 12 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Red Funnel Group Limited | 06 avr. 2016 | Bugle Street SO14 2JY Southampton 12 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
RED FUNNEL FERRIES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 20 juil. 2017 Livré le 27 juil. 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All land (except for restricted land) as listed in schedule 1 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery at any time thereon, intellectual property (except for any restricted ip), and the specified intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the deed of accession and charge registered by this form MR01. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 08 juil. 2016 Livré le 12 juil. 2016 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 25 oct. 2007 Livré le 01 nov. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Red funnel deed of charge | Créé le 21 déc. 2001 Livré le 02 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land and buildings being k/a the red funnel ferry terminal car parks and car marshalling areas east cowes isle of wight t/nos IW49024, IW49023, IW49041, IW42695, IW29058 all f/h land and buildings at fountain quay west cowes t/no IW49025 f/h land and buldings at 10,12,14 and 16 bugle street southampton t/no HP596087 (for full details of all property charged see form 395) together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 oct. 2001 Livré le 26 oct. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present or future obligations of the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents and the mezzanine finance documents (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0