CENTIA LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CENTIA LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04285422 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CENTIA LIMITED ?
Adresse du siège social | Nidderdale House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1SA Harrogate North Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CENTIA LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour CENTIA LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 05 nov. 2018
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jesper Pilholm Trolle en tant que directeur le 08 août 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Mchale en tant qu'administrateur le 08 août 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de Jesper Pilholm Trolle en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 août 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Mark Mchale en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 août 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Kieran David Cooper en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 août 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Arrow Enterprise Computing Solutions Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 août 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2016 avec mises à jour | 9 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Jesper Pilholm Trolle en tant qu'administrateur le 20 mai 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas John Thurlow en tant que directeur le 20 mai 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Grahame Paul Benson en tant que secrétaire le 31 déc. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Grahame Paul Benson en tant que directeur le 31 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Kieran David Cooper en tant que secrétaire le 01 janv. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Kieran David Cooper en tant qu'administrateur le 01 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CENTIA LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOPER, Kieran David | Secrétaire | Nidderdale House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1SA Harrogate North Yorkshire | 204086990001 | |||||||
COOPER, Kieran David | Administrateur | Nidderdale House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1SA Harrogate North Yorkshire | England | British | Cfo | 204083720001 | ||||
MCHALE, Mark | Administrateur | Nidderdale House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1SA Harrogate North Yorkshire | England | British | Director | 237247710001 | ||||
BATES, Graham Christopher | Secrétaire | 4 Belle Avenue RG6 7BL Reading Berkshire | British | 14304070003 | ||||||
BENSON, Grahame Paul | Secrétaire | 5 Blackchapel Drive OL16 4QU Rochdale Lancashire | British | Accountant | 100424970001 | |||||
FORBES, Ronald Harold | Secrétaire | Vale House Ham SN8 3QR Marlborough Wiltshire | British | Director | 14952160001 | |||||
HART, Amanda Judith | Secrétaire | 5 Grange Close SO23 9RS Winchester Hampshire | British | Financial Director | 80624240001 | |||||
BOYES TURNER SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | First Floor Abbots House Abbey Street RG1 3BD Reading Berkshire | 74407280002 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BENSON, Grahame Paul | Administrateur | 5 Blackchapel Drive OL16 4QU Rochdale Lancashire | England | British | Finance Director | 100424970001 | ||||
FORBES, Ronald Harold | Administrateur | Vale House Ham SN8 3QR Marlborough Wiltshire | England | British | Director | 14952160001 | ||||
HART, Amanda Judith | Administrateur | 5 Grange Close SO23 9RS Winchester Hampshire | England | British | Accountant | 80624240001 | ||||
HAWLEY, Nigel Anthony Ashley | Administrateur | Sunningdale Ham SN8 3QS Marlborough Wiltshire | United Kingdom | British | Manager | 2942230001 | ||||
MEHTA, Rajen | Administrateur | 95 Pound Lane Sonning RG4 6GG Reading Berkshire | United Kingdom | British | Director | 156425400001 | ||||
MERELIE, Angus Peter | Administrateur | 14 Elliswick Road AL5 4TP Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Ceo | 84854850001 | ||||
PASEA, Yuri Marcellus | Administrateur | Riverbank 32 West Mills RG14 5HU Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Director | 54640590002 | ||||
PEARCE, Stephen Michael | Administrateur | 2 Curly Hill LS29 0AY Ilkley West Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 120552240001 | ||||
THURLOW, Nicholas John | Administrateur | Nidderdale House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1SA Harrogate North Yorkshire | England | British | Uk Vice President | 137610230001 | ||||
TROLLE, Jesper Pilholm | Administrateur | Nidderdale House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1SA Harrogate North Yorkshire | France | Danish | Vp Uk & Ireland, Benelux And Apac | 208927490001 | ||||
BOYES TURNER DIRECTORS LIMITED | Administrateur | First Floor Abbots House Abbey Street RG1 3BD Reading Berkshire | 101374610001 | |||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CENTIA LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Kieran David Cooper | 30 sept. 2016 | Nidderdale House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1SA Harrogate North Yorkshire | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Mark Mchale | 30 sept. 2016 | Nidderdale House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1SA Harrogate North Yorkshire | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Arrow Enterprise Computing Solutions Ltd | 30 sept. 2016 | Otley Road HG3 1SA Harrogate Nidderdale House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Jesper Pilholm Trolle | 30 sept. 2016 | Nidderdale House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1SA Harrogate North Yorkshire | Oui | ||||||||||
Nationalité: Danish Pays de résidence: France | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Arrow Electronics Inc | 30 sept. 2016 | E. Dry Creek Road Centennial 9201 Co 80112 United States | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
CENTIA LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Créé le 03 oct. 2006 Livré le 11 oct. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 01 sept. 2005 Livré le 09 sept. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 15 nov. 2002 Livré le 25 nov. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 10 oct. 2001 Livré le 23 oct. 2001 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company (formerly known as sync distribution limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0