BADMINTON HEALTHCARE LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBADMINTON HEALTHCARE LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04293809
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BADMINTON HEALTHCARE LTD ?

    • (8514) /

    Où se situe BADMINTON HEALTHCARE LTD ?

    Adresse du siège social
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BADMINTON HEALTHCARE LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour BADMINTON HEALTHCARE LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Angela Culhane en tant que directeur le 25 juin 2012

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    17 pagesAA

    Nomination de Jonathan David Calow en tant que secrétaire le 08 déc. 2011

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Care Uk Services Limited en tant que secrétaire le 08 déc. 2011

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 sept. 2011

    État du capital au 06 sept. 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    17 pagesAA

    Nomination de Paul John Watson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Justin Humphreys le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Care Uk Services Limited le 01 août 2010

    2 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Robert Parish le 10 août 2010

    2 pagesCH01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    28 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    18 pagesAA

    Nomination de Deborah Jane Marriott-Boam en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Geoffrey Benn en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Roy Hastings en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Douglas Umbers en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Angela Hector Culhane en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de BADMINTON HEALTHCARE LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CALOW, Jonathan David
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Secrétaire
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    165428740001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish33223550003
    MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish151689670001
    PARISH, Michael Robert
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    EnglandBritish78828750003
    WATSON, Paul John
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish82460360003
    HELLEY, Theresa
    The Bungalow
    Oat Hedges Farm
    BS27 3RU Cheddar
    Somerset
    Secrétaire
    The Bungalow
    Oat Hedges Farm
    BS27 3RU Cheddar
    Somerset
    British78190350001
    HODGKINS, Leigh
    8 Evergreen
    Charter House
    BS40 7XS Blagdon
    Somerset
    Secrétaire
    8 Evergreen
    Charter House
    BS40 7XS Blagdon
    Somerset
    British117712190001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    British33223550003
    STADDEN, Hilary Anne
    16 Greenleaze Close
    Downend
    BS16 6LW Bristol
    Secrétaire
    16 Greenleaze Close
    Downend
    BS16 6LW Bristol
    British80075380001
    CARE UK SERVICES LIMITED
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2482660
    125332040002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish73786580001
    BOOKER, Roger Ian
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    Administrateur
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish14044530003
    CULHANE, Angela
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    EnglandBritish68602910001
    HASTINGS, Roy
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    Administrateur
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    United KingdomBritish130098430001
    HODGKINS, Maureen
    Evergreen
    Charterhouse On Mendip
    BS40 7SX Blagdon
    Somerset
    Administrateur
    Evergreen
    Charterhouse On Mendip
    BS40 7SX Blagdon
    Somerset
    British78191690005
    HODGKINS, Philip Steven
    Evergreen
    Charterhouse On Mendip
    BS40 7SX Blagdon
    Somerset
    Administrateur
    Evergreen
    Charterhouse On Mendip
    BS40 7SX Blagdon
    Somerset
    British78191730003
    UMBERS, Douglas
    SO53
    Administrateur
    SO53
    United KingdomBritish90541690001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    Administrateur
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    EnglandBritish130512090002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    BADMINTON HEALTHCARE LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 juil. 2010
    Livré le 26 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transactions
    • 26 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 10 déc. 2009
    Livré le 23 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 12 mars 2009
    Livré le 13 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 mars 2004
    Livré le 02 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0