EASTLAKE HOSPITALITY (NEWPORT) LIMITED

EASTLAKE HOSPITALITY (NEWPORT) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEASTLAKE HOSPITALITY (NEWPORT) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04301042
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EASTLAKE HOSPITALITY (NEWPORT) LIMITED ?

    • (5510) /

    Où se situe EASTLAKE HOSPITALITY (NEWPORT) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Somerston Hotels Ltd
    Ryon Hill House, Ryon Hill Park
    CV37 0UX Warwick Road, Stratfordupon
    Avon, Warwickshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EASTLAKE HOSPITALITY (NEWPORT) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EASTLAKE HOSPITALITY (ABINGDON) LIMITED09 oct. 200109 oct. 2001

    Quels sont les derniers comptes de EASTLAKE HOSPITALITY (NEWPORT) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour EASTLAKE HOSPITALITY (NEWPORT) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Darren Lyko-Edwards en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Darren Lyko-Edwards en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Christopher Richard Byrd en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 oct. 2009

    État du capital au 19 oct. 2009

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher David Budden le 19 oct. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages353

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de EASTLAKE HOSPITALITY (NEWPORT) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BYRD, Christopher Richard
    Blackwell
    CV36 4PE Shipston-On-Stour
    Wisty
    Warwickshire
    Secrétaire
    Blackwell
    CV36 4PE Shipston-On-Stour
    Wisty
    Warwickshire
    British151796200001
    BUDDEN, Christopher David
    Chalet Maria Elise
    Chemin D'Alani 22a
    1936 Verbier
    Case Postale 7
    Switzerland
    Administrateur
    Chalet Maria Elise
    Chemin D'Alani 22a
    1936 Verbier
    Case Postale 7
    Switzerland
    SwitzerlandBritishDirector83251320004
    GRIFFITHS, Keith Ian
    82 Greenhill
    WR11 4NH Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    82 Greenhill
    WR11 4NH Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector77782610002
    ROBINSON, Shaun
    41 St Albans Road
    KT2 5HH Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    41 St Albans Road
    KT2 5HH Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director101627760001
    CARDEN-LOVELL, Roderick Hugh
    16 Slicketts Lane
    LU6 2JD Edlesborough
    Bedfordshire
    Secrétaire
    16 Slicketts Lane
    LU6 2JD Edlesborough
    Bedfordshire
    British67776310001
    EVANS, Leslie George
    7 Tanfield Lane
    Rushmere
    NN1 5RG Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    7 Tanfield Lane
    Rushmere
    NN1 5RG Northampton
    Northamptonshire
    BritishHotelier95909460001
    GRIFFITHS, Keith Ian
    82 Greenhill
    WR11 4NH Evesham
    Worcestershire
    Secrétaire
    82 Greenhill
    WR11 4NH Evesham
    Worcestershire
    BritishDirector77782610002
    LYKO-EDWARDS, Darren
    Wake Green Road
    Moseley
    B13 9US Birmingham
    113
    West Midlands
    Secrétaire
    Wake Green Road
    Moseley
    B13 9US Birmingham
    113
    West Midlands
    BritishFinance Director134551380001
    MCCAFFER, Stuart John
    Bowfell
    52 Peel Road
    G74 5AG Thornton Hall
    Glasgow
    Secrétaire
    Bowfell
    52 Peel Road
    G74 5AG Thornton Hall
    Glasgow
    BritishCompany Director64903230004
    TOWERS, Janet Elizabeth
    2 Coopers Close
    Bishopton
    CV37 0RS Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    2 Coopers Close
    Bishopton
    CV37 0RS Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglishAccountant100644030002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    CAMPBELL, Ewan
    Fullarton Drive
    KA10 6LE Troon
    3
    Ayrshire
    Administrateur
    Fullarton Drive
    KA10 6LE Troon
    3
    Ayrshire
    United KingdomBritishCompany Director132607650001
    CARDEN-LOVELL, Roderick Hugh
    16 Slicketts Lane
    LU6 2JD Edlesborough
    Bedfordshire
    Administrateur
    16 Slicketts Lane
    LU6 2JD Edlesborough
    Bedfordshire
    United KingdomBritishDirector67776310001
    ELLINGHAM, Hugh Vere Alexander
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishManaging Director36926690001
    ELLINGHAM, Hugh Vere Alexander
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishDirector36926690001
    EVANS, Leslie George
    7 Tanfield Lane
    Rushmere
    NN1 5RG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    7 Tanfield Lane
    Rushmere
    NN1 5RG Northampton
    Northamptonshire
    BritishHotelier95909460001
    LYKO-EDWARDS, Darren
    Wake Green Road
    Moseley
    B13 9US Birmingham
    113
    West Midlands
    Administrateur
    Wake Green Road
    Moseley
    B13 9US Birmingham
    113
    West Midlands
    United KingdomBritishFinance Director134551380001
    MCCAFFER, Stuart John
    Bowfell
    52 Peel Road
    G74 5AG Thornton Hall
    Glasgow
    Administrateur
    Bowfell
    52 Peel Road
    G74 5AG Thornton Hall
    Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director64903230004
    ROBINSON, Shaun
    41 St Albans Road
    KT2 5HH Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    41 St Albans Road
    KT2 5HH Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishDirector101627760001
    THOMPSON, David George
    14 Grosvenor Crescent
    Dowanhill
    G12 9AF Glasgow
    Administrateur
    14 Grosvenor Crescent
    Dowanhill
    G12 9AF Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director44898070006
    TOWERS, Janet Elizabeth
    2 Coopers Close
    Bishopton
    CV37 0RS Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    2 Coopers Close
    Bishopton
    CV37 0RS Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandEnglishFinance Director100644030002
    WOODCOCK, Louis Peter
    Knapdale
    11 East End Road
    PA12 4ER Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Administrateur
    Knapdale
    11 East End Road
    PA12 4ER Lochwinnoch
    Renfrewshire
    United KingdomBritishCompany Director39601150001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    EASTLAKE HOSPITALITY (NEWPORT) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 25 sept. 2003
    Livré le 04 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property at plot 6200 celtic springs business park cleppa park newport together with all fixtures and fittings and chattels (other than trade machinery as defined in the bill of sales act) goodwill of any trades or business; first fixed charge all money received or to be received in respect of any dealing with the property; contracts; rights and interest to any proceeds of sale; rent and other money under occupancy agreements; floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 sept. 2003
    Livré le 04 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge over all freehold and leasehold property present and future including any trade fixtures fixed plant and machinery; stocks and shares or other interests present and future together with the full benefit of all stocks shares or securities certificates which are held by or on behalf of the company together with all rights; goodwill and uncalled capital present and future together with all book and other debts; first floating charge over the undertaking and heritable property and all other property and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 avr. 2003
    Livré le 02 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Building contract dated 16TH april 2003 between eastlake hospitality (newport) limited and midas construction limited.
    Personnes ayant droit
    • Principality Building Society
    Transactions
    • 02 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 févr. 2003
    Livré le 13 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at plot 6200 celtic springs newport south wales equitable charge all estates or interests in any f/h and l/h property and/or the proceeds of sale thereof specific charge all stocks shares and/or other securities goodwill and the benefit of any licences floating security the company's undertaking and all property and assets and rights whatsoever present and future.
    Personnes ayant droit
    • Principality Building Society
    Transactions
    • 13 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0