POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04307693 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Lynton House 7-12 Tavistock Square WC1H 9LT London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 12 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 déc. 2021 | 11 pages | LIQ03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thorsten Kuhl en tant que directeur le 01 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Ocean House the Ring Bracknell Berkshire RG12 1AN à Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9LT le 05 janv. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jane Li en tant que secrétaire le 31 déc. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Notification de Power Europe Operating Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2018 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Nomination de Mr Jose Fernando Nava en tant qu'administrateur le 01 oct. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de Paul George Dyer en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul George Dyer en tant que directeur le 01 oct. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 19 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Thorsten Kuhl en tant qu'administrateur le 13 juin 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Edward Gill en tant que directeur le 13 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de James Edward Gill en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 juin 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVA, Jose Fernando | Administrateur | 7-12 Tavistock Square WC1H 9LT London Lynton House | England | American | 250985160001 | |||||||||
| LI, Jane | Secrétaire | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Company Secretary Berkshire England | 203650530001 | |||||||||||
| WATERMAN, Matthew Thomas | Secrétaire | Highclere Perry Hill, Worplesdon GU3 3RG Guildford Surrey | British | 43249000002 | ||||||||||
| CLYDE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 51 Eastcheap EC3M 1JP London | 38770650001 | |||||||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
| DUFFY, Christopher William | Administrateur désigné | 7 The Broadwalk HA6 2XD Northwood Middlesex | British | 900005310001 | ||||||||||
| DYER, Paul George | Administrateur | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 112162350001 | |||||||||
| ELLIOTT, Guy | Administrateur | 716a Kenilworth Road CV7 7HD Balsall Common West Midlands | British | 82304100001 | ||||||||||
| GILL, James Edward | Administrateur | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 165998750001 | |||||||||
| KUHL, Thorsten | Administrateur | 7-12 Tavistock Square WC1H 9LT London Lynton House | Germany | German | 247678730001 | |||||||||
| MCNUTT, Dan | Administrateur | 1 Milton Avenue RH4 3QA Westcott Surrey | American | 105073440001 | ||||||||||
| MCNUTT, Daniel | Administrateur | 1 Milton Avenue RH4 3QA Westcott Surrey | American | 78820320001 | ||||||||||
| MORY, Charles Wesley | Administrateur | 1 Birchanger GU7 1PR Godalming Surrey | American | 53912980002 | ||||||||||
| OADES, Stewart | Administrateur | 33 Sunderland Street DN11 9PT Doncaster South Yorkshire | England | British | 105325780001 | |||||||||
| PAGE, David William | Administrateur désigné | Nizels Grove Nizels Lane TN11 8NU Hildenborough Kent | British | 900020260001 | ||||||||||
| SMITH, Keith Roy | Administrateur | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 140889200001 | |||||||||
| SMITH, Keith Roy | Administrateur | Orchards Alhampton BA4 6PZ Shepton Mallet Somerset | British | 91164640002 | ||||||||||
| TAYLOR, Paul Martin | Administrateur | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 105652320002 | |||||||||
| WATERMAN, Matthew Thomas | Administrateur | Highclere Perry Hill, Worplesdon GU3 3RG Guildford Surrey | England | British | 43249000002 | |||||||||
| WATTS, Perry Frederick | Administrateur | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | England | British | 164079770001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Europe Operating Limited | 06 avr. 2018 | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr James Edward Gill | 01 avr. 2017 | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Paul George Dyer | 01 janv. 2017 | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Account charge | Créé le 12 nov. 2001 Livré le 28 nov. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the transaction documents and/or the deed | |
Brèves mentions The deposit (as defined in the account charge) and all the companys right title and benefit both present and future in the deposit. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment by way of security of amounts payable under an operating agreement | Créé le 08 nov. 2001 Livré le 28 nov. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with an operating lease and/or the deed of even date | |
Brèves mentions The right of the company to receive payment of the property charges under an operating agreement dated on or about the date of the framework agreement between lever faberge limited (1) and the mortgagor (2). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 08 nov. 2001 Livré le 16 nov. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All and any of the obligations owed by the company to the chargee arising under or in connection with the transaction documents (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0