POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED

POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPOWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04307693
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?

    • Exploitation d'entrepôts et de terminaux de stockage pour le transport terrestre (52103) / Transports et stockage

    Où se situe POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lynton House
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MINMAR (585) LIMITED19 oct. 200119 oct. 2001

    Quels sont les derniers comptes de POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 déc. 2021

    11 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Thorsten Kuhl en tant que directeur le 01 juin 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Changement d'adresse du siège social de Ocean House the Ring Bracknell Berkshire RG12 1AN à Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9LT le 05 janv. 2021

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 15 déc. 2020

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Jane Li en tant que secrétaire le 31 déc. 2018

    1 pagesTM02

    Notification de Power Europe Operating Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2018

    2 pagesPSC02

    Nomination de Mr Jose Fernando Nava en tant qu'administrateur le 01 oct. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de Paul George Dyer en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2018

    1 pagesPSC07

    Cessation de la nomination de Paul George Dyer en tant que directeur le 01 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    19 pagesAA

    Nomination de Thorsten Kuhl en tant qu'administrateur le 13 juin 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Edward Gill en tant que directeur le 13 juin 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de James Edward Gill en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 juin 2018

    1 pagesPSC07

    Qui sont les dirigeants de POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NAVA, Jose Fernando
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    Administrateur
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    EnglandAmerican250985160001
    LI, Jane
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Company Secretary
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Company Secretary
    Berkshire
    England
    203650530001
    WATERMAN, Matthew Thomas
    Highclere
    Perry Hill, Worplesdon
    GU3 3RG Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Highclere
    Perry Hill, Worplesdon
    GU3 3RG Guildford
    Surrey
    British43249000002
    CLYDE SECRETARIES LIMITED
    51 Eastcheap
    EC3M 1JP London
    Secrétaire
    51 Eastcheap
    EC3M 1JP London
    38770650001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement817717
    32524900007
    DUFFY, Christopher William
    7 The Broadwalk
    HA6 2XD Northwood
    Middlesex
    Administrateur désigné
    7 The Broadwalk
    HA6 2XD Northwood
    Middlesex
    British900005310001
    DYER, Paul George
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish112162350001
    ELLIOTT, Guy
    716a Kenilworth Road
    CV7 7HD Balsall Common
    West Midlands
    Administrateur
    716a Kenilworth Road
    CV7 7HD Balsall Common
    West Midlands
    British82304100001
    GILL, James Edward
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish165998750001
    KUHL, Thorsten
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    Administrateur
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    GermanyGerman247678730001
    MCNUTT, Dan
    1 Milton Avenue
    RH4 3QA Westcott
    Surrey
    Administrateur
    1 Milton Avenue
    RH4 3QA Westcott
    Surrey
    American105073440001
    MCNUTT, Daniel
    1 Milton Avenue
    RH4 3QA Westcott
    Surrey
    Administrateur
    1 Milton Avenue
    RH4 3QA Westcott
    Surrey
    American78820320001
    MORY, Charles Wesley
    1 Birchanger
    GU7 1PR Godalming
    Surrey
    Administrateur
    1 Birchanger
    GU7 1PR Godalming
    Surrey
    American53912980002
    OADES, Stewart
    33 Sunderland Street
    DN11 9PT Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    33 Sunderland Street
    DN11 9PT Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish105325780001
    PAGE, David William
    Nizels Grove
    Nizels Lane
    TN11 8NU Hildenborough
    Kent
    Administrateur désigné
    Nizels Grove
    Nizels Lane
    TN11 8NU Hildenborough
    Kent
    British900020260001
    SMITH, Keith Roy
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish140889200001
    SMITH, Keith Roy
    Orchards
    Alhampton
    BA4 6PZ Shepton Mallet
    Somerset
    Administrateur
    Orchards
    Alhampton
    BA4 6PZ Shepton Mallet
    Somerset
    British91164640002
    TAYLOR, Paul Martin
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish105652320002
    WATERMAN, Matthew Thomas
    Highclere
    Perry Hill, Worplesdon
    GU3 3RG Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Highclere
    Perry Hill, Worplesdon
    GU3 3RG Guildford
    Surrey
    EnglandBritish43249000002
    WATTS, Perry Frederick
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish164079770001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    England
    06 avr. 2018
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3464436
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Mr James Edward Gill
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    01 avr. 2017
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Paul George Dyer
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    01 janv. 2017
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Account charge
    Créé le 12 nov. 2001
    Livré le 28 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the transaction documents and/or the deed
    Brèves mentions
    The deposit (as defined in the account charge) and all the companys right title and benefit both present and future in the deposit.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Leasing Limited
    Transactions
    • 28 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment by way of security of amounts payable under an operating agreement
    Créé le 08 nov. 2001
    Livré le 28 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with an operating lease and/or the deed of even date
    Brèves mentions
    The right of the company to receive payment of the property charges under an operating agreement dated on or about the date of the framework agreement between lever faberge limited (1) and the mortgagor (2).
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Leasing Limited
    Transactions
    • 28 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 nov. 2001
    Livré le 16 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All and any of the obligations owed by the company to the chargee arising under or in connection with the transaction documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lever Faberge Limited
    Transactions
    • 16 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)

    POWER EUROPE (DONCASTER) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 déc. 2020Commencement of winding up
    18 janv. 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jonathan David Bass
    Menzies Llp Lynton House
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    practitioner
    Menzies Llp Lynton House
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Freddy Khalastchi
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    practitioner
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0