ROLLERDELL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROLLERDELL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04307781
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROLLERDELL LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ROLLERDELL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7th Floor 9 Berkeley Street
    W1J 8DW London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ROLLERDELL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour ROLLERDELL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de 3500 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AL à 7th Floor 9 Berkeley Street London W1J 8DW le 07 juil. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    16 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 nov. 2015

    État du capital au 24 nov. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    7 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 oct. 2014

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 nov. 2014

    État du capital au 25 nov. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * 3Rd Floor 22 Grafton Street London W1S 4EX United Kingdom* le 23 janv. 2014

    2 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 oct. 2013 sans liste des membres

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 nov. 2013

    État du capital au 11 nov. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Sixth Floor 63 Curzon Street London W1J 8PD* le 22 nov. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    12 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Nigel Le Quesne en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Saffron Harrop en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Roberto Monticelli en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Miranda Lansdowne en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Anthony Underwood-Whitney en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Philip Burgin en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Castle Directors Limited en tant qu'administrateur

    3 pagesAP02

    Nomination de Jtc Directors Limited en tant qu'administrateur

    3 pagesAP02

    Modification des coordonnées du secrétaire Jtc Management Limited le 21 mai 2012

    3 pagesCH04

    Nomination de Martin Gordon Cudlipp en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de ROLLERDELL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JTC JERSEY LIMITED
    9 Castle Street
    St Helier
    JE4 2QP Jersey
    P O Box 1075 Elizabeth House
    Channel Isles
    Secrétaire
    9 Castle Street
    St Helier
    JE4 2QP Jersey
    P O Box 1075 Elizabeth House
    Channel Isles
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement37293
    160251780002
    CUDLIPP, Martin Gordon
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey Channel Islands
    Administrateur
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey Channel Islands
    JerseyBritish172570330001
    CASTLE DIRECTORS LIMITED
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Administrateur
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement102673
    170374650001
    JTC DIRECTORS LIMITED
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Administrateur
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement100165
    170374460001
    ANDERSON, Samuel Kenneth
    23 Brooklands Crescent
    Whitehead
    BT38 9SW Carrick Fergus
    Secrétaire
    23 Brooklands Crescent
    Whitehead
    BT38 9SW Carrick Fergus
    British145693280001
    BRABNERS SECRETARIES LIMITED
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    79429720001
    CAPITA TRUSTEES SERVICES LIMITED
    Aib House
    25 Esplanade
    JE2 3QA St Helier
    Channel Islands
    Secrétaire
    Aib House
    25 Esplanade
    JE2 3QA St Helier
    Channel Islands
    85248580003
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ANDERSON, Samuel Kenneth
    23 Brooklands Crescent
    Whitehead
    BT38 9SW Carrick Fergus
    Administrateur
    23 Brooklands Crescent
    Whitehead
    BT38 9SW Carrick Fergus
    British145693280001
    BARRETT, Linda Jane
    La Rue De Carteret
    Rue Des Pres St. Saviour
    JE2 7RA Jersey
    4
    Administrateur
    La Rue De Carteret
    Rue Des Pres St. Saviour
    JE2 7RA Jersey
    4
    British135027860001
    BAUDAINS, James Kenneth
    La Rue Mathurin
    Grouville
    JE3 9GZ Jersey
    Springvale
    Channel Isles
    Administrateur
    La Rue Mathurin
    Grouville
    JE3 9GZ Jersey
    Springvale
    Channel Isles
    British136150950001
    BLAMPIED, Michael Norman
    Rue De Guilleaume Et D'Anneville
    St.Martin
    JE3 6DP Jersey
    Perinne
    Channel Islands
    Administrateur
    Rue De Guilleaume Et D'Anneville
    St.Martin
    JE3 6DP Jersey
    Perinne
    Channel Islands
    UkBritish150439570001
    BURGIN, Philip Henry
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Administrateur
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyEnglish120326900007
    CROSSLAND, Anne
    Daisy Hill House
    La Chevre Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    Administrateur
    Daisy Hill House
    La Chevre Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    British25971110004
    CROSSLAND, David
    Daisy Hill House
    La Cheuve Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    Administrateur
    Daisy Hill House
    La Cheuve Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    JerseyBritish3977330005
    CROWE, Anthony Charles
    La Cache De La Ronde
    Seapoint Le Grande Route De La Cote
    JE2 6BR St. Clement
    6
    Jersey
    Administrateur
    La Cache De La Ronde
    Seapoint Le Grande Route De La Cote
    JE2 6BR St. Clement
    6
    Jersey
    British135028380001
    DUCKWORTH, Roger Ian
    Mayfield
    Huntercombe
    RG9 0RR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Mayfield
    Huntercombe
    RG9 0RR Henley On Thames
    Oxfordshire
    British674980002
    FRY, Chrispian Francis Anstee
    Woodville Avenue
    St. Helier
    JE2 4AP Jersey
    40 Woodville Apartments
    Channel Isles
    Administrateur
    Woodville Avenue
    St. Helier
    JE2 4AP Jersey
    40 Woodville Apartments
    Channel Isles
    JerseyBritish191605130001
    GORROD, Joanne Louise
    Upper Kings Cliff
    St. Helier
    JE2 3GP Jersey
    2 Thornton Hall
    Channel Isles
    Administrateur
    Upper Kings Cliff
    St. Helier
    JE2 3GP Jersey
    2 Thornton Hall
    Channel Isles
    Jersey, Channel IslandsBritish175845830001
    HARROP, Saffron Louise
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Administrateur
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish,120408490001
    LANSDOWNE, Miranda Suzanne Helen
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Administrateur
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Jersey Channel IslandsBritish160253960001
    LE COUILLIARD, David Philip
    La Rue Des Pallieres
    St. Ouen
    JE3 2BB Jersey
    Le Passage
    Channel Isles
    Administrateur
    La Rue Des Pallieres
    St. Ouen
    JE3 2BB Jersey
    Le Passage
    Channel Isles
    Jersey Channel IslesBritish135028580001
    LE QUESNE, Nigel Anthony
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Administrateur
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish71675010004
    MONTICELLI, Roberto
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Administrateur
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish148791260001
    ROGERS, Peter John
    Fulmans Abbey Spring Lane
    Beaulieu
    SO42 7YT Brockenhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Fulmans Abbey Spring Lane
    Beaulieu
    SO42 7YT Brockenhurst
    Hampshire
    United KingdomBritish143297040001
    TUGHAN, Frederick David
    Portavo House 176 Warren Road
    BT21 0PJ Donaghadee
    Co Down
    Administrateur
    Portavo House 176 Warren Road
    BT21 0PJ Donaghadee
    Co Down
    Northern IrelandBritish203412740001
    UNDERWOOD-WHITNEY, Anthony James
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Administrateur
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish160254210001
    WHEELER, Lorraine Fay
    La Rue Des Vignes
    St. Peter
    JE3 7YL Jersey
    L'Ailette
    Channel Isles
    Administrateur
    La Rue Des Vignes
    St. Peter
    JE3 7YL Jersey
    L'Ailette
    Channel Isles
    Channel IslandsBritish100921140001
    AIBJT CORPORATE LIMITED
    Aib House
    25 Esplanade
    JE2 3QA St Helier
    Channel Islands
    Administrateur
    Aib House
    25 Esplanade
    JE2 3QA St Helier
    Channel Islands
    92635870003
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    ROLLERDELL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Acession deed
    Créé le 06 janv. 2006
    Livré le 18 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All f/h or l/h property,its interest in any present or future licences,the rental income,all present and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible moveable property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 18 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 22 juil. 2002
    Livré le 31 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a link 414, chestnut avenue, chandlers ford, eastleigh t/no. HP614206. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 juil. 2002
    Livré le 31 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party legal charge
    Créé le 16 avr. 2002
    Livré le 04 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due or to become due from marlin investments limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as link 414 chestnut ave,chandlers ford eastleigh hampshire; t/no HP605200; all buildings fixtures fittings fixed plant and machinery thereon; fixed charge over the benefit of all contracts,licence,right,covenant.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Limited
    Transactions
    • 04 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0