C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéC.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04316721
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Upper Berkeley Street
    London
    W1H 7PE
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    C.G.I.S. SALISBURY LIMITED28 nov. 200128 nov. 2001
    DWSCO 2212 LIMITED05 nov. 200105 nov. 2001

    Quels sont les derniers comptes de C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 11 juil. 2016

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 déc. 2015

    État du capital au 01 déc. 2015

    • Capital: GBP 3,023.24
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 nov. 2014

    État du capital au 18 nov. 2014

    • Capital: GBP 3,023.24
    SH01

    Satisfaction de la charge 043167210008 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 juin 2013

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2013

    État du capital au 16 déc. 2013

    • Capital: GBP 3,023.24
    SH01

    Inscription de la charge 043167210008

    32 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2012

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    legacy

    8 pagesMG01

    Qui sont les dirigeants de C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STEINBERG, Mark Neil
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    Secrétaire
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    British59275730001
    COLE, Terence Shelby
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    Administrateur
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    United KingdomBritish71810060003
    COLLINS, Steven Ross
    Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PL London
    70
    Administrateur
    Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PL London
    70
    United KingdomBritish7128850001
    STEINBERG, Mark Neil
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    Administrateur
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    United KingdomBritish59275730001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Secrétaire désigné
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023840001
    DWS DIRECTORS LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Administrateur désigné
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023830001

    C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 06 sept. 2013
    Livré le 20 sept. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Sculptor Finance (Md) Limited
    Transactions
    • 20 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 01 juil. 2010
    Livré le 12 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties (or any of them) or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge all its undertaking and all property assets and rights.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 12 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 22 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge all its undertaking and all its property, assets and rights both present and future.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for and on Behalf of Thelenders
    Transactions
    • 22 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fifty-fifth supplemental trust deed
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 12 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by hemingway debenture limited to the trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the new property being f/h land k/a plot 5300 being part of land at tewkesbury business park northway lane tewkesbury t/n GR248788. F/h land being la fitness (also k/a north birmingham squash rackets club) 366 gravelly lane erdington birmingham t/n's WM108627 WN682318 WM232394 WM629635 and WM744301. L/h land at mill street brierley hill west midlands t/n WM775455. For further details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 mai 2005
    Livré le 06 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h land known as part plot 5300, tewkesbury business park northway lane tewkesbury t/n GR248788, fixed and floating charges over the undertaking and all property present and future including goodwill uncalled capital fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 06 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deeds of accession to a subordination deed dated 24 december 2002 pursuant to which the company will become an obligor and subordinated creditor under the subordination deed and
    Créé le 20 mars 2003
    Livré le 02 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by an obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All present and future liabilities and obligations payable or owing by an obligor to any subordinated creditor, assign or puport to assign to any person the whole or any part of the subordinated liabilities, purport to set off at any time any amount, attempt to obtain repayment or prepayment of principal or payment of any interest, fees or commissions on, or by reference to, any of the subordinated liabilities otherwise than in accordance with the terms of the deed;.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Security Trustee for Thefinance Parties)
    Transactions
    • 02 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 mars 2003
    Livré le 02 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and any other chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Security Trustee for Thefinance Parties)
    Transactions
    • 02 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 avr. 2002
    Livré le 17 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The whole of the property (including uncalled capital) which is may be from time to time comprised in the property and undertaking of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0