AMARYLLIS GROUP LTD
Vue d'ensemble
Nom de la société | AMARYLLIS GROUP LTD |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04318206 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AMARYLLIS GROUP LTD ?
Adresse du siège social | Recovery House Hainault Business Park 15-17 Roebuck Road IG6 3TU Ilford Essex |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AMARYLLIS GROUP LTD ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 29 sept. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour AMARYLLIS GROUP LTD ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 18 pages | LIQ14 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Recovery House Hainault Business Park 15-17 Roebuck Road Ilford Essex IG6 3TU à Recovery House Hainault Business Park 15-17 Roebuck Road Ilford Essex IG6 3TU le 14 sept. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Broadfans Barn Cherry Street Duton Hill Dunmow Essex CM6 2EE England à Recovery House Hainault Business Park 15-17 Roebuck Road Ilford Essex IG6 3TU le 11 sept. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration des affaires | 8 pages | LIQ02 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 043182060005 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 043182060006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été suspendue | 1 pages | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Retrait de la demande de radiation de la société | 1 pages | DS02 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gavin Ashley Mann en tant que secrétaire le 14 janv. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 29 sept. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 Elliot Drive Springwood Industrial Estate Braintree Essex CM7 2GD à Broadfans Barn Cherry Street Duton Hill Dunmow Essex CM6 2EE le 07 nov. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de AMARYLLIS GROUP LTD ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KING, David Richard | Administrateur | Hainault Business Park 15-17 Roebuck Road IG6 3TU Ilford Recovery House Essex | England | British | Company Director | 92253870002 | ||||
BRIARS, Mark Anthony | Secrétaire | Galleydene SS7 2QA Hadleigh 21 Essex United Kingdom | British | Chartered Accountant | 135777020001 | |||||
CHAPMAN, Kieran Paul | Secrétaire | 64 Windmill Road CO9 1JN Halstead Essex | British | Accountant | 119140190001 | |||||
IEVERS, Michael John Eyre | Secrétaire | 86 Gillhurst Road Harbourne B17 8PA Birmingham West Midlands | British | Director | 80584980001 | |||||
IEVERS, Michael John Eyre | Secrétaire | 86 Gillhurst Road Harbourne B17 8PA Birmingham West Midlands | British | Director | 80584980001 | |||||
MANN, Gavin Ashley | Secrétaire | Cherry Street Duton Hill CM6 2EE Dunmow Broadfans Barn Essex England | 147035740001 | |||||||
MCMELLON, Christopher John | Secrétaire | 12 Grovehill Crescent TR11 3HR Falmouth Cornwall | British | 43249730003 | ||||||
SINCLAIR, Rebecca Claire | Secrétaire | South Woodham Ferrers CM3 5QU Essex Fennbrook House | British | 132717880001 | ||||||
STEAD, Russell Anthony | Secrétaire | Martens Meadow CM7 3LB Braintree 48 Essex | British | 136405960001 | ||||||
WINTER, Thomas George | Secrétaire | Bonython House Bicknacre Road CM3 4JR Danbury Essex | British | Accountant | 92253520001 | |||||
INGLEBY NOMINEES LIMITED | Secrétaire désigné | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||
BELDEAU, Michael Henri | Administrateur | Summerhill House 16 Meadway KT10 9HF Esher Surrey | British | Director | 76429710002 | |||||
BRIARS, Mark Anthony | Administrateur | Galleydene SS7 2QA Hadleigh 21 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 135777020001 | ||||
FIRTH, Steven | Administrateur | 8 Poplar Grove BD19 6JG Cleckheaton West Yorkshire | England | British | Director | 104177470001 | ||||
IEVERS, Michael John Eyre | Administrateur | 86 Gillhurst Road Harbourne B17 8PA Birmingham West Midlands | Uk | British | Company Director | 80584980001 | ||||
KNIGHT, Joanna Felicity | Administrateur | The Orchard Mill Lane, Earl Stonham IP14 5HS Stowmarket | England | British | Marketing | 35903430004 | ||||
KNIGHT, Joanna Felicity | Administrateur | The Orchard Mill Lane, Earl Stonham IP14 5HS Stowmarket | England | British | Company Director | 35903430004 | ||||
LOCHANS, David | Administrateur | Amaryllis House Montrose Road CM2 6TE Chelmsford Essex | United Kingdom | British | Managing Director | 180210040001 | ||||
MCMELLON, Christopher John | Administrateur | 12 Grovehill Crescent TR11 3HR Falmouth Cornwall | England | British | Company Secretary | 43249730003 | ||||
PAPPS, Andrew John | Administrateur | Elliot Drive Springwood Industrial Estate CM7 2GD Braintree 2 Essex England | United Kingdom | British | Human Resourses | 148250050001 | ||||
PRESTON, Graham John | Administrateur | Baytrees 31 Priests Lane CM15 8BU Brentwood Essex | England | British | None | 100555620001 | ||||
PRICE, William Frederick Ernest | Administrateur | Willowbrook 20 High Street Wheatley OX33 1XX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Business Consultant | 24187260001 | ||||
ROCKS, Ben John | Administrateur | Springwood Drive Springwood Industrial Estate CM7 2GB Braintree 2 Essex England | England | British | Finance Director | 194664190001 | ||||
STEAD, Russell Anthony | Administrateur | Martens Meadow Hedgerows CM7 3LB Braintree 46 Essex | United Kingdom | British | Financial Director | 137565000001 | ||||
WINTER, Thomas George | Administrateur | Bonython House Bicknacre Road CM3 4JR Danbury Essex | England | British | Accountant | 92253520001 | ||||
INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Administrateur désigné | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007850001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AMARYLLIS GROUP LTD ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr David Richard King | 06 avr. 2016 | Hainault Business Park 15-17 Roebuck Road IG6 3TU Ilford Recovery House Essex | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
|
AMARYLLIS GROUP LTD a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 16 sept. 2016 Livré le 03 oct. 2016 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein tothe chargee on anyaccount whatsoever. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 12 août 2014 Livré le 12 août 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 20 oct. 2010 Livré le 27 oct. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 30 sept. 2004 Livré le 02 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 25 nov. 2003 Livré le 02 déc. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 déc. 2002 Livré le 09 janv. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
AMARYLLIS GROUP LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0