AMARYLLIS GROUP LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAMARYLLIS GROUP LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04318206
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AMARYLLIS GROUP LTD ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe AMARYLLIS GROUP LTD ?

    Adresse du siège social
    Recovery House Hainault Business Park
    15-17 Roebuck Road
    IG6 3TU Ilford
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AMARYLLIS GROUP LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AMARYLLIS LIMITED27 mars 200227 mars 2002
    INGLEBY (1463) LIMITED07 nov. 200107 nov. 2001

    Quels sont les derniers comptes de AMARYLLIS GROUP LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 sept. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour AMARYLLIS GROUP LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pagesLIQ14
    YB5LKJG9

    Changement d'adresse du siège social de Recovery House Hainault Business Park 15-17 Roebuck Road Ilford Essex IG6 3TU à Recovery House Hainault Business Park 15-17 Roebuck Road Ilford Essex IG6 3TU le 14 sept. 2021

    2 pagesAD01
    AACK4Q3S

    Changement d'adresse du siège social de Broadfans Barn Cherry Street Duton Hill Dunmow Essex CM6 2EE England à Recovery House Hainault Business Park 15-17 Roebuck Road Ilford Essex IG6 3TU le 11 sept. 2021

    2 pagesAD01
    AACCJMR6

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600
    AACCJMQY

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 01 sept. 2021

    LRESEX

    Déclaration des affaires

    8 pagesLIQ02
    AACCJMQI

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A9ZSW0VL

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04
    X9YDJFH4

    Satisfaction de la charge 043182060005 en totalité

    1 pagesMR04
    X9YDJG1V

    Satisfaction de la charge 043182060006 en totalité

    1 pagesMR04
    X9YDJGEO

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Retrait de la demande de radiation de la société

    1 pagesDS02
    X84FAX3F

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A81RQ9JC

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X8089M0X

    Cessation de la nomination de Gavin Ashley Mann en tant que secrétaire le 14 janv. 2019

    1 pagesTM02
    X8089KOQ

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes pour une petite entreprise établis au 29 sept. 2017

    7 pagesAA
    X7IAL2E0

    Changement d'adresse du siège social de 2 Elliot Drive Springwood Industrial Estate Braintree Essex CM7 2GD à Broadfans Barn Cherry Street Duton Hill Dunmow Essex CM6 2EE le 07 nov. 2018

    1 pagesAD01
    X7I6MGVS

    Qui sont les dirigeants de AMARYLLIS GROUP LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KING, David Richard
    Hainault Business Park
    15-17 Roebuck Road
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    Administrateur
    Hainault Business Park
    15-17 Roebuck Road
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    EnglandBritishCompany Director92253870002
    BRIARS, Mark Anthony
    Galleydene
    SS7 2QA Hadleigh
    21
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Galleydene
    SS7 2QA Hadleigh
    21
    Essex
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant135777020001
    CHAPMAN, Kieran Paul
    64 Windmill Road
    CO9 1JN Halstead
    Essex
    Secrétaire
    64 Windmill Road
    CO9 1JN Halstead
    Essex
    BritishAccountant119140190001
    IEVERS, Michael John Eyre
    86 Gillhurst Road
    Harbourne
    B17 8PA Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    86 Gillhurst Road
    Harbourne
    B17 8PA Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector80584980001
    IEVERS, Michael John Eyre
    86 Gillhurst Road
    Harbourne
    B17 8PA Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    86 Gillhurst Road
    Harbourne
    B17 8PA Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector80584980001
    MANN, Gavin Ashley
    Cherry Street
    Duton Hill
    CM6 2EE Dunmow
    Broadfans Barn
    Essex
    England
    Secrétaire
    Cherry Street
    Duton Hill
    CM6 2EE Dunmow
    Broadfans Barn
    Essex
    England
    147035740001
    MCMELLON, Christopher John
    12 Grovehill Crescent
    TR11 3HR Falmouth
    Cornwall
    Secrétaire
    12 Grovehill Crescent
    TR11 3HR Falmouth
    Cornwall
    British43249730003
    SINCLAIR, Rebecca Claire
    South Woodham Ferrers
    CM3 5QU Essex
    Fennbrook House
    Secrétaire
    South Woodham Ferrers
    CM3 5QU Essex
    Fennbrook House
    British132717880001
    STEAD, Russell Anthony
    Martens Meadow
    CM7 3LB Braintree
    48
    Essex
    Secrétaire
    Martens Meadow
    CM7 3LB Braintree
    48
    Essex
    British136405960001
    WINTER, Thomas George
    Bonython House
    Bicknacre Road
    CM3 4JR Danbury
    Essex
    Secrétaire
    Bonython House
    Bicknacre Road
    CM3 4JR Danbury
    Essex
    BritishAccountant92253520001
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Secrétaire désigné
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    BELDEAU, Michael Henri
    Summerhill House
    16 Meadway
    KT10 9HF Esher
    Surrey
    Administrateur
    Summerhill House
    16 Meadway
    KT10 9HF Esher
    Surrey
    BritishDirector76429710002
    BRIARS, Mark Anthony
    Galleydene
    SS7 2QA Hadleigh
    21
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    Galleydene
    SS7 2QA Hadleigh
    21
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant135777020001
    FIRTH, Steven
    8 Poplar Grove
    BD19 6JG Cleckheaton
    West Yorkshire
    Administrateur
    8 Poplar Grove
    BD19 6JG Cleckheaton
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector104177470001
    IEVERS, Michael John Eyre
    86 Gillhurst Road
    Harbourne
    B17 8PA Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    86 Gillhurst Road
    Harbourne
    B17 8PA Birmingham
    West Midlands
    UkBritishCompany Director80584980001
    KNIGHT, Joanna Felicity
    The Orchard
    Mill Lane, Earl Stonham
    IP14 5HS Stowmarket
    Administrateur
    The Orchard
    Mill Lane, Earl Stonham
    IP14 5HS Stowmarket
    EnglandBritishMarketing35903430004
    KNIGHT, Joanna Felicity
    The Orchard
    Mill Lane, Earl Stonham
    IP14 5HS Stowmarket
    Administrateur
    The Orchard
    Mill Lane, Earl Stonham
    IP14 5HS Stowmarket
    EnglandBritishCompany Director35903430004
    LOCHANS, David
    Amaryllis House
    Montrose Road
    CM2 6TE Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Amaryllis House
    Montrose Road
    CM2 6TE Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishManaging Director180210040001
    MCMELLON, Christopher John
    12 Grovehill Crescent
    TR11 3HR Falmouth
    Cornwall
    Administrateur
    12 Grovehill Crescent
    TR11 3HR Falmouth
    Cornwall
    EnglandBritishCompany Secretary43249730003
    PAPPS, Andrew John
    Elliot Drive
    Springwood Industrial Estate
    CM7 2GD Braintree
    2
    Essex
    England
    Administrateur
    Elliot Drive
    Springwood Industrial Estate
    CM7 2GD Braintree
    2
    Essex
    England
    United KingdomBritishHuman Resourses148250050001
    PRESTON, Graham John
    Baytrees
    31 Priests Lane
    CM15 8BU Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Baytrees
    31 Priests Lane
    CM15 8BU Brentwood
    Essex
    EnglandBritishNone100555620001
    PRICE, William Frederick Ernest
    Willowbrook 20 High Street
    Wheatley
    OX33 1XX Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Willowbrook 20 High Street
    Wheatley
    OX33 1XX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishBusiness Consultant24187260001
    ROCKS, Ben John
    Springwood Drive
    Springwood Industrial Estate
    CM7 2GB Braintree
    2
    Essex
    England
    Administrateur
    Springwood Drive
    Springwood Industrial Estate
    CM7 2GB Braintree
    2
    Essex
    England
    EnglandBritishFinance Director194664190001
    STEAD, Russell Anthony
    Martens Meadow
    Hedgerows
    CM7 3LB Braintree
    46
    Essex
    Administrateur
    Martens Meadow
    Hedgerows
    CM7 3LB Braintree
    46
    Essex
    United KingdomBritishFinancial Director137565000001
    WINTER, Thomas George
    Bonython House
    Bicknacre Road
    CM3 4JR Danbury
    Essex
    Administrateur
    Bonython House
    Bicknacre Road
    CM3 4JR Danbury
    Essex
    EnglandBritishAccountant92253520001
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Administrateur désigné
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AMARYLLIS GROUP LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr David Richard King
    Hainault Business Park
    15-17 Roebuck Road
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    06 avr. 2016
    Hainault Business Park
    15-17 Roebuck Road
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    AMARYLLIS GROUP LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 16 sept. 2016
    Livré le 03 oct. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein tothe chargee on anyaccount whatsoever. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • 4SYTE Funding Limited
    Transactions
    • 03 oct. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 août 2014
    Livré le 12 août 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Commercial Finance PLC
    Transactions
    • 12 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 20 oct. 2010
    Livré le 27 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 2004
    Livré le 02 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 nov. 2003
    Livré le 02 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Land Securities PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 déc. 2002
    Livré le 09 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Land Securities PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    AMARYLLIS GROUP LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 sept. 2022Due to be dissolved on
    01 sept. 2021Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan John Clark
    Carter Clark Recovery House
    15-17 Roebuck Road, Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Essex
    practitioner
    Carter Clark Recovery House
    15-17 Roebuck Road, Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Essex

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0