BIRSE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

BIRSE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBIRSE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04319675
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BIRSE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED ?

    • Construction d'ouvrages d'art hydrauliques (42910) / Construction

    Où se situe BIRSE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o MAZARS LLP
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Greater London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BIRSE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BIRSE WATER LIMITED21 févr. 200221 févr. 2002
    HAMSARD 2426 LIMITED08 nov. 200108 nov. 2001

    Quels sont les derniers comptes de BIRSE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour BIRSE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 sept. 2017

    9 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Andrew Robert Astin en tant que directeur le 28 mars 2017

    2 pagesTM01

    Déclaration de solvabilité

    4 pages4.70

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Kingsgate High Street Redhill RH1 1SG England à 5 Churchill Place Canary Wharf London E14 5HU

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU England à C/O Mazars Llp Tower Bridge House St Katharines Way London Greater London E1W 1DD le 01 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 06 sept. 2016

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Nomination de David Andrew Bruce en tant qu'administrateur le 01 juin 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stuart Edward Curl en tant que directeur le 31 mai 2016

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul David England le 09 déc. 2015

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Stuart Edward Curl en tant qu'administrateur le 01 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Andrew Robert Astin en tant qu'administrateur le 01 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Emma Campbell en tant que directeur le 31 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Bnoms Limited le 09 déc. 2015

    1 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de 130 Wilton Road London SW1V 1LQ à 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU le 09 déc. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 oct. 2015

    État du capital au 26 oct. 2015

    • Capital: GBP 2,000,000
    SH01

    Nomination de Bnoms Limited en tant que secrétaire le 01 oct. 2015

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Gregory William Mutch en tant que secrétaire le 30 sept. 2015

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de Beverley Edward John Dew en tant que directeur le 05 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul David England en tant qu'administrateur le 05 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Lloyd Cutler en tant que directeur le 11 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BIRSE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BNOMS LIMITED
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Secrétaire
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement624621
    174017860001
    BRUCE, David Andrew
    c/o Mazars Llp
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Greater London
    Administrateur
    c/o Mazars Llp
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Greater London
    EnglandBritish208824540001
    ENGLAND, Paul David
    c/o Mazars Llp
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Greater London
    Administrateur
    c/o Mazars Llp
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Greater London
    EnglandBritish153205540001
    CAMPBELL, Emma
    3 Grimston Grange
    Sherburn Road
    LS24 9BX Tadcaster
    North Yorkshire
    Secrétaire
    3 Grimston Grange
    Sherburn Road
    LS24 9BX Tadcaster
    North Yorkshire
    154949820001
    JAECKEL, Christine Charlotte
    Apartment 16 Chorlegh Grange
    Chapel Road
    SK9 7GL Alderley Edge
    Cheshire
    Secrétaire
    Apartment 16 Chorlegh Grange
    Chapel Road
    SK9 7GL Alderley Edge
    Cheshire
    British91764060004
    MORRIS, Philip Hugh
    Station Road
    RH1 1PQ Redhill
    86
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Station Road
    RH1 1PQ Redhill
    86
    Surrey
    United Kingdom
    149951790001
    MUTCH, Gregory William
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    Secrétaire
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    173317520001
    THRALL, Timothy Mark
    Three Oaks
    Park Avenue Barlow
    YO8 8JH Selby
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Three Oaks
    Park Avenue Barlow
    YO8 8JH Selby
    North Yorkshire
    British81710370002
    BIRSE GROUP SERVICES LIMITED
    Humber Road
    DN18 5BW Barton Upon Humber
    North Lincolnshire
    Secrétaire
    Humber Road
    DN18 5BW Barton Upon Humber
    North Lincolnshire
    80848720001
    HSE SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secrétaire
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580006
    ADAMS, Robert
    7 Isle Close
    Crowle
    DN17 4NR Scunthorpe
    Lincolnshire
    Administrateur
    7 Isle Close
    Crowle
    DN17 4NR Scunthorpe
    Lincolnshire
    EnglandBritish81709840001
    ASTIN, Andrew Robert
    c/o Mazars Llp
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Greater London
    Administrateur
    c/o Mazars Llp
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Greater London
    EnglandBritish200138200001
    BUDDEN, Martin, M
    Newlands
    8 Thorner Lane
    LS14 3AR Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Newlands
    8 Thorner Lane
    LS14 3AR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127509870001
    BUDDEN, Martin, M
    Newlands
    8 Thorner Lane
    LS14 3AR Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Newlands
    8 Thorner Lane
    LS14 3AR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127509870001
    CAMPBELL, Emma
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    ScotlandBritish187263100001
    CRAVEN, Heather Ann
    6 Norwood
    Carleton
    WF8 3SD Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    6 Norwood
    Carleton
    WF8 3SD Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish110004900001
    CURL, Stuart Edward
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    EnglandBritish95957100001
    CUTLER, Mark Lloyd
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    Administrateur
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    EnglandBritish185822570001
    DEW, Beverley Edward John
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    Administrateur
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    EnglandBritish133103950001
    EASTON, Murray John
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    Administrateur
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    EnglandBritish62486170001
    JAECKEL, Christine Charlotte
    Apartment 16 Chorlegh Grange
    Chapel Road
    SK9 7GL Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    Apartment 16 Chorlegh Grange
    Chapel Road
    SK9 7GL Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomBritish91764060004
    JOHNSON, Mark Richard
    3 Grimston Grange
    Sherburn Road
    LS24 9BX Tadcaster
    North Yorkshire
    Administrateur
    3 Grimston Grange
    Sherburn Road
    LS24 9BX Tadcaster
    North Yorkshire
    United KingdomBritish61083530002
    MACAULAY, Hector
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    Administrateur
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    EnglandBritish158731120001
    RUANE, John
    16 Oakfield Close
    Bramhall
    SK7 1JE Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    16 Oakfield Close
    Bramhall
    SK7 1JE Stockport
    Cheshire
    British65162710002
    SCOTT, Marshall Duncan
    3 Grimston Grange
    Sherburn Road
    LS24 9BX Tadcaster
    North Yorkshire
    Administrateur
    3 Grimston Grange
    Sherburn Road
    LS24 9BX Tadcaster
    North Yorkshire
    ScotlandBritish983730001
    THRALL, Timothy Mark
    Three Oaks
    Park Avenue Barlow
    YO8 8JH Selby
    North Yorkshire
    Administrateur
    Three Oaks
    Park Avenue Barlow
    YO8 8JH Selby
    North Yorkshire
    EnglandBritish81710370002
    WALSH, John Anthony Meade
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    Administrateur
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    United KingdomBritish238138720001
    WARDMAN, Dave
    3 Strands Court
    Netherton
    WF4 4JB Wakefield
    Yorkshire
    Administrateur
    3 Strands Court
    Netherton
    WF4 4JB Wakefield
    Yorkshire
    British81709910001
    HSE DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    England
    Administrateur
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    England
    73774730002

    BIRSE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed
    Créé le 30 juin 2004
    Livré le 05 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company respectively charged in the manner referred to in clause 3.1 of the debentures and clause 2 of the chattel mortgage all of its assets as more specifically therein referred to upon the terms in all respects therein contained. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 05 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets present & future , including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery
    Créé le 30 avr. 2002
    Livré le 09 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets present & future , including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 09 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BIRSE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 sept. 2016Commencement of winding up
    07 nov. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0