SPIRIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

SPIRIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSPIRIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04320672
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SPIRIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SPIRIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Westgate Brewery
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Suffolk
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SPIRIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PM FINANCIAL HOLDINGS LIMITED29 janv. 200229 janv. 2002
    TRUSHELFCO (NO.2858) LIMITED12 nov. 200112 nov. 2001

    Quels sont les derniers comptes de SPIRIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SPIRIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au20 nov. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation04 déc. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au20 nov. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SPIRIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2025 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    legacy

    108 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2024 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023

    19 pagesAA

    legacy

    110 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Statuts

    10 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    État du capital au 21 nov. 2023

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 01 janv. 2023

    21 pagesAA

    Nomination de Mr Simon Nicholas D'cruz en tant qu'administrateur le 31 mars 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Matthew Robert Lee en tant que directeur le 31 mars 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 02 janv. 2022

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Richard Smothers en tant que directeur le 15 oct. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Matthew Robert Lee en tant qu'administrateur le 15 oct. 2021

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 03 janv. 2021

    22 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SPIRIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESWICK, Lindsay Anne
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Secrétaire
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    207524360001
    D'CRUZ, Simon Nicholas
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242723610001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592430001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445310001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022300001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secrétaire
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Secrétaire désigné
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIES, Hywel Lloyd
    39 Calvert Road
    Greenwich
    SE10 0DH London
    Administrateur
    39 Calvert Road
    Greenwich
    SE10 0DH London
    British89442840001
    DAVIES, Kathryn Ruth
    16 Elgin Mews South
    W9 1JZ London
    Administrateur
    16 Elgin Mews South
    W9 1JZ London
    British80075670001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Administrateur
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    LEE, Matthew Robert
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish286667680001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PEEL, Stephen Mark
    4 Neville Street
    SW7 3AR London
    Administrateur
    4 Neville Street
    SW7 3AR London
    British54712990002
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    PRESTON, Neil David
    Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    57
    Staffordshire
    Administrateur
    Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    57
    Staffordshire
    United KingdomBritish63043630002
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Administrateur
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwiss78412270001
    SMITH, Benedict James
    Flat 9
    62 Eccleston Square
    SW1V 1PH London
    Administrateur
    Flat 9
    62 Eccleston Square
    SW1V 1PH London
    United KingdomBritish75231110001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242658700001
    STOKER, Louise Jane
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    Administrateur
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    British96079800001
    STONE, Stephen John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131652460001
    THORLEY, Giles Alexander
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Gb-EngBritish81928120001
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    14 St Mary's Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Bucks
    Administrateur désigné
    14 St Mary's Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Bucks
    British900019290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SPIRIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4271971
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0