TRINITY CABLES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRINITY CABLES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04332545
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRINITY CABLES LIMITED ?

    • (3130) /

    Où se situe TRINITY CABLES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TRINITY CABLES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour TRINITY CABLES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 avr. 2015

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 janv. 2015

    7 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 juil. 2014

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 janv. 2014

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 juil. 2013

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 janv. 2013

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 juil. 2012

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 janv. 2012

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 juil. 2011

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 janv. 2011

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 juil. 2010

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 janv. 2010

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages287

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 16 janv. 2009

    8 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    8 pages2.34B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 août 2008

    7 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 août 2008

    6 pages2.24B

    legacy

    1 pages287

    Résultat de la réunion des créanciers

    21 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    24 pages2.17B

    Déclaration des affaires

    8 pages2.16B

    Qui sont les dirigeants de TRINITY CABLES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BISWAS, Shyamal Kumar
    11 Buttermere Avenue
    Acklam
    TS5 7BE Middlesbrough
    Cleveland
    Administrateur
    11 Buttermere Avenue
    Acklam
    TS5 7BE Middlesbrough
    Cleveland
    United KingdomBritishRestauranteur61070040001
    SABHARWAL, Anil Kumar
    3 Coombe Way
    Hartburn
    TS18 5PX Stockton On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    3 Coombe Way
    Hartburn
    TS18 5PX Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishProduction Manager79524010001
    RATHI, Narendra Kumar
    29 West End Way
    TS18 3UA Stockton On Tees
    Cleveland
    Secrétaire
    29 West End Way
    TS18 3UA Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishExecutive Manager79523670001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BHAMBRA, Jaspal Singh
    190 Hamstead Road
    Handsworth
    B20 2RE Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    190 Hamstead Road
    Handsworth
    B20 2RE Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishExecutive Manager15996440001
    BHAMBRA, Tarnjit Kaur
    190 Hamstead Road
    Handsworth
    B20 2RE Birmingham
    Warwickshire
    Administrateur
    190 Hamstead Road
    Handsworth
    B20 2RE Birmingham
    Warwickshire
    BritishNone98884540001
    BISWAS, Shyamal Kumar
    11 Buttermere Avenue
    Acklam
    TS5 7BE Middlesbrough
    Cleveland
    Administrateur
    11 Buttermere Avenue
    Acklam
    TS5 7BE Middlesbrough
    Cleveland
    United KingdomBritishRestauranteur61070040001
    RATHI, Narendra Kumar
    29 West End Way
    TS18 3UA Stockton On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    29 West End Way
    TS18 3UA Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishExecutive Manager79523670001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Administrateur désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    TRINITY CABLES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of debenture
    Créé le 27 nov. 2006
    Livré le 01 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and each associate on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • State Securities PLC
    Transactions
    • 01 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of mortgage over land and chattels
    Créé le 27 nov. 2006
    Livré le 01 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and each associate on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property k/a hall number one, darlington road t/no DU273381 all the goodwill, all of its right, title and interest in the mortgaged chattels assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • State Securities PLC
    Transactions
    • 01 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 11 mai 2006
    Livré le 12 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 12 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 10 avr. 2006
    Livré le 18 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Cable stocks and all raw materials from time to time including wire compounds tapes and drums,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Draka UK LTD
    Transactions
    • 18 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 mars 2006
    Livré le 02 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property being land at hall number one darlington road durham t/n DU73381.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 02 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 10 janv. 2005
    Livré le 11 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1) mpi rod breakdown machine with annealer & spooler s/n MPI1; 2) one bobbin drum 800MM; 3) 20 x bobbin spools 630MM; see form 395 for other chattels charged.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 11 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 juil. 2004
    Livré le 13 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Aptec enterprise house darlington road west auckland co durham. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 13 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 27 nov. 2003
    Livré le 28 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached hereto or any part thereof;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 28 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 24 nov. 2003
    Livré le 25 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (the Security Holder)
    Transactions
    • 25 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 06 nov. 2003
    Livré le 07 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things being ceeco 1000 mm single twist machine, s/no 13-1113, watson pairing line 560MM NB560 with payoffs s/no 13-5429/K933, complete cable extrusion line S1 maellefer 80MM s/no 68-1702A, or any part thereof for details of further chattels charged please refer to the form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 07 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 sept. 2003
    Livré le 02 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TRINITY CABLES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 mai 2006Date of meeting to approve CVA
    02 mars 2007Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Leighton Cockshott
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    practitioner
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    2
    DateType
    13 août 2007Administration started
    22 janv. 2009Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter Kubik
    Uhy Hacker Young
    St Alphage House
    EC2Y 5DH 2 Fore Street
    London
    practitioner
    Uhy Hacker Young
    St Alphage House
    EC2Y 5DH 2 Fore Street
    London
    Andrew Andronikou
    Hacker Young & Partners
    St Alphage House
    EC2Y 5DH 2 Fore Street
    London
    practitioner
    Hacker Young & Partners
    St Alphage House
    EC2Y 5DH 2 Fore Street
    London
    3
    DateType
    22 janv. 2009Commencement of winding up
    05 juin 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Andronikou
    Quadrant House 17 Thomas More Street
    Thomas More Square
    E1W 1YW London
    practitioner
    Quadrant House 17 Thomas More Street
    Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Peter Kubik
    Quadrant House 17 Thomas More Street
    Thomas More Square
    E1W 1YW London
    practitioner
    Quadrant House 17 Thomas More Street
    Thomas More Square
    E1W 1YW London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0