PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED

PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04336523
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TELAVIN LIMITED07 déc. 200107 déc. 2001

    Quels sont les derniers comptes de PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 02 août 2010

    9 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 03 août 2010

    9 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 mai 2010

    6 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 nov. 2009

    8 pages2.24B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    61 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    44 pages2.16B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2007

    24 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages395

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WEAVER, Jayne Marie
    49 Needham Drive
    CW4 8FB Cranage
    Cheshire
    Secrétaire
    49 Needham Drive
    CW4 8FB Cranage
    Cheshire
    British84919130001
    BRAZIER, Peter
    19 The Groves
    Riverside
    CH1 1SD Chester
    Cheshire
    Administrateur
    19 The Groves
    Riverside
    CH1 1SD Chester
    Cheshire
    United KingdomBritishManaging Director90415850001
    GOULDING, Michael John
    4 Forestway
    PR25 1HL Leyland
    Administrateur
    4 Forestway
    PR25 1HL Leyland
    BritishCommercial Director126863270001
    LUCAS, Christa
    Woodlea
    Old Tram Road, Penwortham
    PR1 9TY Preston
    Administrateur
    Woodlea
    Old Tram Road, Penwortham
    PR1 9TY Preston
    EnglandSwissProduct Marketing Director126876280001
    O'CONNOR, Sean Stuart
    25 Finlay Street
    SW6 6HE London
    Administrateur
    25 Finlay Street
    SW6 6HE London
    EnglandBritishCompany Director20369370001
    WEAVER, Guy Michael Linsley
    49 Needham Drive
    CW4 8FB Cranage
    Cheshire
    Administrateur
    49 Needham Drive
    CW4 8FB Cranage
    Cheshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer84919050002
    MCGEE, Richard Andrew
    38 Berkley Close
    CO4 9RR Colchester
    Essex
    Secrétaire
    38 Berkley Close
    CO4 9RR Colchester
    Essex
    BritishAdministrator88095540001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    EASTWOOD, Janet
    81 Norwich Drive
    Upton
    L49 4GJ Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    81 Norwich Drive
    Upton
    L49 4GJ Wirral
    Merseyside
    BritishFinance Director41259340001
    HOLT, Tara
    Greenwood
    Blakemere Lane, Norley
    WA6 6NS Frodsham
    Administrateur
    Greenwood
    Blakemere Lane, Norley
    WA6 6NS Frodsham
    BritishMarketing Services Director126876290001
    MCGEE, John Joseph
    Aston Lodge, 22 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NU Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Aston Lodge, 22 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NU Chelmsford
    Essex
    BritishFinancial Consultant64773330001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of deposit
    Créé le 17 juil. 2007
    Livré le 30 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit initially of £175,000 credited to account designation 17690366 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2007
    Livré le 19 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Paul Sykes and Sarah Sykes
    Transactions
    • 19 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 nov. 2003
    Livré le 19 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2003
    Livré le 08 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)

    PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 août 2010Administration ended
    12 mai 2009Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    David James Kelly
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    practitioner
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0