BRAVECITY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRAVECITY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04338442
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRAVECITY LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BRAVECITY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    17 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QG
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BRAVECITY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BRAVECITY LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BRAVECITY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mai 2012

    État du capital au 08 mai 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    12 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Divers

    Sect 519
    2 pagesMISC

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Glenn Maud le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Glenn Maud le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Cessation de la nomination de Gabriel Mclaughlin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de Mette Geddes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Saunders en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    14 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de BRAVECITY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAUD, Glenn
    Wilton Crescent
    SW1X 8RN London
    4
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wilton Crescent
    SW1X 8RN London
    4
    United Kingdom
    British77818210001
    MAUD, Glenn
    Wilton Crescent
    SW1X 8RN London
    4
    United Kingdom
    Administrateur
    Wilton Crescent
    SW1X 8RN London
    4
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director77818210001
    SOUTHERN, Timothy Robin
    56 Wood Vale
    SE23 3ED London
    Secrétaire
    56 Wood Vale
    SE23 3ED London
    BritishSolicitor63884070001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    TARLO LYONS SECRETARIES LIMITED
    Watchmaker Court
    33 St Johns Lane
    EC1M 4DB London
    Secrétaire
    Watchmaker Court
    33 St Johns Lane
    EC1M 4DB London
    106974360001
    FROHNSDORFF, David
    Grosvenor Street
    W1K 4QG London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QG London
    17
    United Kingdom
    BritishPartner117523270003
    GEDDES, Mette
    St. Philips Avenue
    KT4 8LA Worcester Park
    Surrey
    Administrateur
    St. Philips Avenue
    KT4 8LA Worcester Park
    Surrey
    United KingdomDanishPa108452870002
    MAUD, Patricia Ann
    17 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Administrateur
    17 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    BritishCompany Director77816490001
    MCLAUGHLIN, Gabriel
    Tring Road
    Northchurch
    HP4 3TL Berkhamsted
    Hamberlins
    Hertfordshire
    Administrateur
    Tring Road
    Northchurch
    HP4 3TL Berkhamsted
    Hamberlins
    Hertfordshire
    United KingdomBritishPartner141889290001
    O'HARE, Genevieve
    23 Gloucester Avenue
    Primrose Hills
    NW1 7AU London
    Administrateur
    23 Gloucester Avenue
    Primrose Hills
    NW1 7AU London
    IrishChartered Surveyor99750000001
    SAUNDERS, Peter John
    35 Stone Yard Plumptre Street
    NG1 1JL Nottingham
    Administrateur
    35 Stone Yard Plumptre Street
    NG1 1JL Nottingham
    United KingdomBritishPartner149140450001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    BRAVECITY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of debenture
    Créé le 16 mars 2006
    Livré le 05 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H emc tower (formerly k/a data general tower) great west road brentford middlesex t/no AGL16790. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Landesbank as Agent and Security Trustee for Itself and the Other Beneficiaries
    Transactions
    • 05 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2005
    Livré le 18 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land k/a ecm tower (formerly k/a data general tower) great west road, brentford, middlesex t/no AGL16790. F/h and l/h land k/a prescot shopping centre, prescot, merseyside t/no's MS269564, MS219577, MS372823 and MS456161. F/h subjects k/a ugc cinema, camperdown leisure park, kingsway west, dundee t/no ang 308. for details of further property charged please refer to form 395. by way of legal mortgage all of its rights in the properties, by way of fixed charge all of its other rights in any land. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC 'the Security Trustee'
    Transactions
    • 18 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 2005
    Livré le 22 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers, each property owning subsidiary or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all of its rights in the property and by way of fixed charge all of its right in any land (other than land in scotland) assigns a) rental income b) occupational leases and other documents c) insurance d) external hedging agreements. By way of fixed charge chattels, goodwill, bank accounts, book and other debts, shares, intellectual property rights, licences and other documents. By way of floating charge all assets not mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 2005
    Livré le 22 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 mai 2004
    Livré le 02 juin 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers, each property owning subsidiary or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h land known as ecm tower (formerly known as data general tower) great west road brentford middlesex t/no AGL16790 and other land together with all rights in buildings structures erections fixtures and fittings. Assigns a) rental income b) occupational leases and other documents c) insurance d) external hedging agreements. By way of fixed charge chattels, goodwill, bank accounts, book and other debts, shares, intellectual property rights, licences and other documents. By way of floating charge all assets not mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks, P.L.C
    Transactions
    • 02 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Shares charge
    Créé le 13 mai 2004
    Livré le 02 juin 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers, each property owning subsidiary or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights in and to its shares and any rights or other assets including any I) dividends ii) distributions iii) interest and other income iv) voting rights v) other benefits, money or property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks, P.L.C. (The Security Trustee)
    Transactions
    • 02 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 mai 2004
    Livré le 28 mai 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land known as ecm tower (formerly known as data general tower) great west road brentford middlesex t/no AGL16790, the l/h land known as the pavements shopping centre chesterfield t/no DY231907 and the f/h and l/h land known as prescot shopping centre prescot merseyside t/nos MS372823 and MS456161. For details of further properties charged please refer to form 395. assignment of rental income and occupational leases and other documents. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Share mortgage
    Créé le 06 août 2003
    Livré le 19 août 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Mortgaged and charged and agreed to mortgage and charge to the bank all of the shares, the same to be a security by way of a first mortgage and mortgaged and charged and agreed to mortgage and charge to the bank all the related rights accruing to all or any of the shares, the same to be a security by way of a first mortgage or charge;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage of shares
    Créé le 23 janv. 2002
    Livré le 28 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All of the shares and all the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of debenture
    Créé le 23 janv. 2002
    Livré le 28 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)

    BRAVECITY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 mars 2013Petition date
    02 déc. 2014Conclusion of winding up
    13 mai 2013Commencement of winding up
    12 mars 2015Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    practitioner
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0