LIVING AMBITIONS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LIVING AMBITIONS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04340843 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LIVING AMBITIONS LIMITED ?
Adresse du siège social | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LIVING AMBITIONS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 03 avr. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LIVING AMBITIONS LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour LIVING AMBITIONS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Divers Section 519 | 4 pages | MISC | ||||||||||
Divers Section 519 | 4 pages | MISC | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Justin Humphreys en tant que directeur le 07 oct. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Philip James Whitecross en tant qu'administrateur le 06 mai 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 03 avr. 2014 au 31 mars 2014 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Deborah Jane Marriott-Lavery en tant que directeur le 06 mai 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 03 avr. 2013 | 12 pages | AA | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 03 avr. 2013
| 4 pages | SH01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2013 au 03 avr. 2013 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed watson group healthcare LTD\certificate issued on 29/04/13 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Nomination de Paul John Watson en tant qu'administrateur le 04 avr. 2013 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Deborah Jane Marriott-Lavery en tant qu'administrateur le 04 avr. 2013 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Dardsley Brownedge Road Lostock Hall Preston Lancashire PR5 5AD le 22 avr. 2013 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Colin Howard Preston en tant que secrétaire le 04 avr. 2013 | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter George Watson en tant que directeur le 04 avr. 2013 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ralph Benjamin Watson en tant que directeur le 04 avr. 2013 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Justin Humphreys en tant qu'administrateur le 04 avr. 2013 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael Robert Parish en tant qu'administrateur le 04 avr. 2013 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jonathan David Calow en tant que secrétaire le 04 avr. 2013 | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LIVING AMBITIONS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALOW, Jonathan David | Secrétaire | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | 177578200001 | |||||||
PARISH, Michael Robert | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | England | British | Company Director | 78828750003 | ||||
WATSON, Paul John | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 82460360003 | ||||
WHITECROSS, Philip James | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | England | British | Company Director | 193730760001 | ||||
MELIA, Michael Leonard | Secrétaire | Highland House 17 Clarksfield Street OL4 3AW Oldham | British | 69653200002 | ||||||
MORTON, Laura | Secrétaire | 240 Darwen Road Bromley Cross BL7 9JQ Bolton Lancashire | British | Operations Manager | 98533320001 | |||||
MULLINEAUX, William Thomas | Secrétaire | 7 Cowley Crescent Padiham BB12 8SX Burnley Lancashire | British | 113115860001 | ||||||
PRESTON, Colin Howard | Secrétaire | 1 Pall Mall Cottages Rivington Lane BL6 7RY Horwich Lancashire | British | 123059890001 | ||||||
PRESTON, Mary | Secrétaire | 1 Pall Mall Cottage Rivington Lane BL6 7RY Bolton | British | Manager Director | 124068010001 | |||||
HUMPHREYS, Paul Justin | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | Company Director | 33223550003 | ||||
MARRIOTT-LAVERY, Deborah Jane | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 151689670002 | ||||
WATSON, Peter George | Administrateur | Preston New Road Westby PR4 3PH Preston Staining Wood Farm England | England | British | Business Proprietor | 79423100010 | ||||
WATSON, Peter George | Administrateur | Fairways Drive Mount Murray IM4 2JD Braddan 127 Isle Of Man | British | Business Proprietor | 79423100005 | |||||
WATSON, Ralph Benjamin | Administrateur | Didsbury Plaza 2 Central Road M20 4ZD Manchester 14 Lancashire | England | British | Business Man | 136599380005 |
LIVING AMBITIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 12 mai 2003 Livré le 14 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 12 mai 2003 Livré le 14 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal mortgage over all that f/h property k/a simonsfield land on the north side and land adjacent to boston avenue runcorn t/nos CH501923 CH501924. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 12 mai 2003 Livré le 14 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal mortgage over all that f/h property k/a hannah and olivia court land and buildings on the east side of sadler street widnes t/no CH442365. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 avr. 2002 Livré le 15 avr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0