LIVING AMBITIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLIVING AMBITIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04340843
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LIVING AMBITIONS LIMITED ?

    • Autres activités de travail social sans hébergement n.c.a. (88990) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe LIVING AMBITIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LIVING AMBITIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WATSON GROUP HEALTHCARE LTD28 juin 200728 juin 2007
    LIVING AMBITIONS LTD19 févr. 200719 févr. 2007
    WATSON GROUP HEALTHCARE LIMITED 14 déc. 200114 déc. 2001

    Quels sont les derniers comptes de LIVING AMBITIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au03 avr. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LIVING AMBITIONS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour LIVING AMBITIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 déc. 2014

    État du capital au 29 déc. 2014

    • Capital: GBP 1,112
    SH01

    Divers

    Section 519
    4 pagesMISC

    Divers

    Section 519
    4 pagesMISC

    Cessation de la nomination de Paul Justin Humphreys en tant que directeur le 07 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Philip James Whitecross en tant qu'administrateur le 06 mai 2014

    2 pagesAP01

    Période comptable précédente raccourcie du 03 avr. 2014 au 31 mars 2014

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Deborah Jane Marriott-Lavery en tant que directeur le 06 mai 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 03 avr. 2013

    12 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 03 avr. 2013

    • Capital: GBP 1,112
    4 pagesSH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2013 au 03 avr. 2013

    1 pagesAA01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed watson group healthcare LTD\certificate issued on 29/04/13
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination de Paul John Watson en tant qu'administrateur le 04 avr. 2013

    3 pagesAP01

    Nomination de Mrs Deborah Jane Marriott-Lavery en tant qu'administrateur le 04 avr. 2013

    3 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Dardsley Brownedge Road Lostock Hall Preston Lancashire PR5 5AD le 22 avr. 2013

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Colin Howard Preston en tant que secrétaire le 04 avr. 2013

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Peter George Watson en tant que directeur le 04 avr. 2013

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ralph Benjamin Watson en tant que directeur le 04 avr. 2013

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Justin Humphreys en tant qu'administrateur le 04 avr. 2013

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Michael Robert Parish en tant qu'administrateur le 04 avr. 2013

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Jonathan David Calow en tant que secrétaire le 04 avr. 2013

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de LIVING AMBITIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CALOW, Jonathan David
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Secrétaire
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    177578200001
    PARISH, Michael Robert
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    EnglandBritishCompany Director78828750003
    WATSON, Paul John
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant82460360003
    WHITECROSS, Philip James
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    EnglandBritishCompany Director193730760001
    MELIA, Michael Leonard
    Highland House
    17 Clarksfield Street
    OL4 3AW Oldham
    Secrétaire
    Highland House
    17 Clarksfield Street
    OL4 3AW Oldham
    British69653200002
    MORTON, Laura
    240 Darwen Road
    Bromley Cross
    BL7 9JQ Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    240 Darwen Road
    Bromley Cross
    BL7 9JQ Bolton
    Lancashire
    BritishOperations Manager98533320001
    MULLINEAUX, William Thomas
    7 Cowley Crescent
    Padiham
    BB12 8SX Burnley
    Lancashire
    Secrétaire
    7 Cowley Crescent
    Padiham
    BB12 8SX Burnley
    Lancashire
    British113115860001
    PRESTON, Colin Howard
    1 Pall Mall Cottages
    Rivington Lane
    BL6 7RY Horwich
    Lancashire
    Secrétaire
    1 Pall Mall Cottages
    Rivington Lane
    BL6 7RY Horwich
    Lancashire
    British123059890001
    PRESTON, Mary
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    Secrétaire
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    BritishManager Director124068010001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director33223550003
    MARRIOTT-LAVERY, Deborah Jane
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director151689670002
    WATSON, Peter George
    Preston New Road
    Westby
    PR4 3PH Preston
    Staining Wood Farm
    England
    Administrateur
    Preston New Road
    Westby
    PR4 3PH Preston
    Staining Wood Farm
    England
    EnglandBritishBusiness Proprietor79423100010
    WATSON, Peter George
    Fairways Drive
    Mount Murray
    IM4 2JD Braddan
    127
    Isle Of Man
    Administrateur
    Fairways Drive
    Mount Murray
    IM4 2JD Braddan
    127
    Isle Of Man
    BritishBusiness Proprietor79423100005
    WATSON, Ralph Benjamin
    Didsbury Plaza
    2 Central Road
    M20 4ZD Manchester
    14
    Lancashire
    Administrateur
    Didsbury Plaza
    2 Central Road
    M20 4ZD Manchester
    14
    Lancashire
    EnglandBritishBusiness Man136599380005

    LIVING AMBITIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 mai 2003
    Livré le 14 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 12 mai 2003
    Livré le 14 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage over all that f/h property k/a simonsfield land on the north side and land adjacent to boston avenue runcorn t/nos CH501923 CH501924. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 12 mai 2003
    Livré le 14 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage over all that f/h property k/a hannah and olivia court land and buildings on the east side of sadler street widnes t/no CH442365. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 2002
    Livré le 15 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0