MERCURY SERVICES MANAGEMENT LIMITED

MERCURY SERVICES MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMERCURY SERVICES MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04342286
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MERCURY SERVICES MANAGEMENT LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe MERCURY SERVICES MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Oakley
    Kidderminster Road
    WR9 9AY Droitwich
    Worcestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MERCURY SERVICES MANAGEMENT LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2016
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2017
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour MERCURY SERVICES MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 déc. 2015

    État du capital au 18 déc. 2015

    • Capital: GBP 1,002
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Quinn le 15 juin 2015

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 115 Popes Lane Oldbury West Midlands B69 4PA à The Oakley Kidderminster Road Droitwich Worcestershire WR9 9AY le 09 sept. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 déc. 2014

    État du capital au 18 déc. 2014

    • Capital: GBP 1,002
    SH01

    Cessation de la nomination de Simon Brian Williams en tant que directeur le 29 août 2014

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon Brian Williams en tant que directeur le 29 août 2014

    2 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Simon Brian Williams le 06 août 2014

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 janv. 2014

    État du capital au 30 janv. 2014

    • Capital: GBP 1,002
    SH01

    État du capital après une attribution d'actions au 05 déc. 2013

    • Capital: GBP 1,002
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    41 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Simon Brian Williams le 21 nov. 2012

    3 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Annulation d'actions. État du capital au 15 oct. 2012

    • Capital: GBP 36
    4 pagesSH06

    Rachat d'actions propres.

    3 pagesSH03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Duncan Williams en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Duncan Williams en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Purchase by the company of shares 16/09/2012
    RES13

    Qui sont les dirigeants de MERCURY SERVICES MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    QUINN, David
    Kidderminster Road
    WR9 9AY Droitwich
    The Oakley
    Worcestershire
    England
    Administrateur
    Kidderminster Road
    WR9 9AY Droitwich
    The Oakley
    Worcestershire
    England
    EnglandBritishEngineer80001830002
    BONELLO, Lesley Ann
    11 Warwick Avenue
    B60 2AH Bromsgrove
    Worcestershire
    Secrétaire
    11 Warwick Avenue
    B60 2AH Bromsgrove
    Worcestershire
    British102907400001
    WILLIAMS, Duncan Raymond
    Fermoy House Shepley Meadow
    Shepley Road Barnt Green
    B45 8JN Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    Fermoy House Shepley Meadow
    Shepley Road Barnt Green
    B45 8JN Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector30366770004
    OAKLEY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Oakley
    Kidderminster Road
    WR9 9AY Droitwich Spa
    Worcestershire
    Secrétaire
    The Oakley
    Kidderminster Road
    WR9 9AY Droitwich Spa
    Worcestershire
    84255710001
    WILLIAMS, Duncan Raymond
    Fermoy House Shepley Meadow
    Shepley Road Barnt Green
    B45 8JN Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    Fermoy House Shepley Meadow
    Shepley Road Barnt Green
    B45 8JN Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector30366770004
    WILLIAMS, Duncan Raymond
    Fermoy House Shepley Meadow
    Shepley Road Barnt Green
    B45 8JN Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    Fermoy House Shepley Meadow
    Shepley Road Barnt Green
    B45 8JN Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishEngineer30366770004
    WILLIAMS, Simon Brian
    Popes Lane
    B69 4PA Oldbury
    115
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Popes Lane
    B69 4PA Oldbury
    115
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritishConsultant94068940006
    OAKLEY CORPORATE DOCTORS LIMITED
    The Oakley
    Kidderminster Road
    WR9 9AY Droitwich Spa
    Worcestershire
    Administrateur
    The Oakley
    Kidderminster Road
    WR9 9AY Droitwich Spa
    Worcestershire
    84255700001

    MERCURY SERVICES MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 16 avr. 2010
    Livré le 17 avr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 17 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 22 juil. 2008
    Livré le 24 juil. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 08 mars 2007
    Livré le 13 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 29 juil. 2005
    Livré le 03 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 29 mars 2005
    Livré le 30 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Addition to an omnibus letter of set-off
    Créé le 11 mars 2003
    Livré le 31 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank in any currency.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 31 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture deed
    Créé le 03 déc. 2002
    Livré le 11 déc. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0