TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED

TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04346502
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THISTLE EDINBURGH LIMITED01 mars 200201 mars 2002
    PETERTRAIL LIMITED03 janv. 200203 janv. 2002

    Quels sont les derniers comptes de TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mai 2013
    Date d'échéance des prochains comptes28 févr. 2014
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 janv. 2017

    8 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 nov. 2016

    10 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    5 pages600

    legacy

    2 pagesAC93

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 sept. 2014

    6 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 mars 2014

    8 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Cheryl Frances Moharm le 07 janv. 2013

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 janv. 2013

    État du capital au 07 janv. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom

    1 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2012

    5 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Eddie Zakay le 03 avr. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2010

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOHARM, Cheryl Frances
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Secrétaire
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    British74265400001
    BUSH, Clive Edward
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Administrateur
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    EnglandBritish62062860002
    MOHARM, Cheryl Frances
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Administrateur
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    United KingdomBritish74265400003
    ZAKAY, Eddie
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Administrateur
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    United KingdomBritish8477470004
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    CATTERMOLE, Ian Kendall
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British82666030001
    DURANT, Ian Charles
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    Secrétaire
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    British150020002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    CATTERMOLE, Ian Kendall
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British82666030001
    DURANT, Ian Charles
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    Administrateur
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish150020002
    FAIRLEY, Neil Duff
    72 Carr Road
    Calverley
    LS28 5RH Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    72 Carr Road
    Calverley
    LS28 5RH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish78198900001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Administrateur désigné
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MOK, Rayman
    PO BOX 44790
    101 Buckingham Palace Road
    SW1W 0WA London
    Administrateur
    PO BOX 44790
    101 Buckingham Palace Road
    SW1W 0WA London
    Singaporean101871540001
    NEWSOME, Gillian Anne
    15 Layton Lane
    Rawdon
    LS19 6RQ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    15 Layton Lane
    Rawdon
    LS19 6RQ Leeds
    West Yorkshire
    British70404230001
    O'MAHONEY, Michael
    44 Beechcroft Manor
    KT13 9NZ Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    44 Beechcroft Manor
    KT13 9NZ Weybridge
    Surrey
    British84990810001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    WILDEN, Nichola Jane
    12c Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    Administrateur
    12c Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    EnglandBritish24856300002
    ZAKAY, Sol
    46 Avenue Road
    NW8 6HS London
    Administrateur
    46 Avenue Road
    NW8 6HS London
    United KingdomBritish26053220007

    TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A standard security presented for registration in scotland on the 3RD may 2005 and
    Créé le 28 avr. 2005
    Livré le 18 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limted to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the tenants interest in the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh being the lease between murrayfield (tolcross) limited and scottish and newcastle breweries limited dated the 6TH may, 11TH july and 9TH august 1974. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 18 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignation of rents on 4TH may 2005
    Créé le 28 avr. 2005
    Livré le 18 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limited to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company`s whole right title and interest in and to the rent and all other monies due and to become due to the company in terms of the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh dated the 28TH april 2005. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 18 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 28 avr. 2005
    Livré le 07 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The tenant's interest in the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh t/no MID22327. By way of fixed charge all moneys standing to the credit of the charged accounts, the benefits in respect of the insurances, all rights under each occupational lease, the benefit of all licences, all rights under the assigned agreements, all shares and related rights. By way of floating charge the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    Transactions
    • 07 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 avr. 2017Due to be dissolved on
    04 mars 2013Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0