REDAB KILBURN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREDAB KILBURN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04348331
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REDAB KILBURN LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe REDAB KILBURN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    167 Turners Hill
    EN8 9BH Cheshunt
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REDAB KILBURN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REDAB FARRINGDON LIMITED07 juin 200207 juin 2002
    OAKTRADE LIMITED07 janv. 200207 janv. 2002

    Quels sont les derniers comptes de REDAB KILBURN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour REDAB KILBURN LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour REDAB KILBURN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 30 mars 2015

    • Capital: GBP 1,000
    5 pagesSH02

    Comptes annuels établis au 31 mai 2014

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 janv. 2015

    État du capital au 23 janv. 2015

    • Capital: GBP 3,795,000
    SH01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mai 2013

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 janv. 2014

    État du capital au 13 janv. 2014

    • Capital: GBP 3,795,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Carl Gustav Pettersson le 11 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    7 pagesMG01

    legacy

    6 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2012

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2010

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de REDAB KILBURN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SUNDGREN, Berit Maria
    Turners Hill
    EN8 9BH Cheshunt
    167
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Turners Hill
    EN8 9BH Cheshunt
    167
    Hertfordshire
    Swedish37389250003
    PETTERSSON, Karl Gustav
    Turners Hill
    EN8 9BH Cheshunt
    167
    Hertfordshire
    Administrateur
    Turners Hill
    EN8 9BH Cheshunt
    167
    Hertfordshire
    United KingdomSwedish46933230002
    SUNDGREN, Berit Maria
    Turners Hill
    EN8 9BH Cheshunt
    167
    Hertfordshire
    Administrateur
    Turners Hill
    EN8 9BH Cheshunt
    167
    Hertfordshire
    United KingdomSwedish37389250003
    ROBERTSON, Douglas Laurence
    19 Old Barn Close
    Kemsing
    TN15 6RZ Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    19 Old Barn Close
    Kemsing
    TN15 6RZ Sevenoaks
    Kent
    British76235680001
    L.C.I. SECRETARIES LIMITED
    74 Lynn Road
    Terrington Saint Clement
    PE34 4JX Kings Lynn
    Norfolk
    Secrétaire désigné
    74 Lynn Road
    Terrington Saint Clement
    PE34 4JX Kings Lynn
    Norfolk
    900015390001
    ROBERTSON, Douglas Laurence
    19 Old Barn Close
    Kemsing
    TN15 6RZ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    19 Old Barn Close
    Kemsing
    TN15 6RZ Sevenoaks
    Kent
    British76235680001
    L.C.I. DIRECTORS LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    Administrateur désigné
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    900013970001

    REDAB KILBURN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over deposit account
    Créé le 13 déc. 2012
    Livré le 20 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £166,000 deposited in account number 90176302 and any other sums deposited.
    Personnes ayant droit
    • United Trust Bank Limited
    Transactions
    • 20 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 13 déc. 2012
    Livré le 14 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land being land and buildings at cedar lodge, exeter road and jubilee heights, 1 shoot up hill, willesden. T/no MX362679 and all rights relating to the property in existence at the date of the mortgage. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • United Trust Bank Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 déc. 2012
    Livré le 14 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Cedar lodge, exeter road and jubilee heights, 1 shoot up hill, willesden t/no MX362679 and all rights relating to the property. Fixed and floating charge over the undertaking and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • United Trust Bank Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of rental assignment
    Créé le 09 févr. 2009
    Livré le 11 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title benefit and interest in and to all rent licence fees or other sums of money received or recoverable by the company from any tenant or licencee of the property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 11 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 09 févr. 2009
    Livré le 11 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 11 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge on deposit
    Créé le 09 févr. 2009
    Livré le 11 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All sums standing to the credit of the company in deposit account number 0133779150 with the bank of ireland.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 11 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 09 févr. 2009
    Livré le 11 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Cedar lodge exeter road and jubilee heights, 1 shoot up hill, willesden t/n MX362679 and all buildings, fixtures & fixed plant & machinery & equipment from time to time thereon all right title & interest to, & in any proceeds of any present and future insurances of the property. Any present & future goodwill of the business see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 11 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 16 juil. 2002
    Livré le 23 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 23 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 25 mars 2002
    Livré le 02 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent for the beneficiaries (as defined) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Investments (as defined) and any dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 mars 2002
    Livré le 02 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent for the beneficiaries (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0