RMAC 2002-NS1 PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRMAC 2002-NS1 PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 04349853
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RMAC 2002-NS1 PLC ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe RMAC 2002-NS1 PLC ?

    Adresse du siège social
    5 Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de RMAC 2002-NS1 PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour RMAC 2002-NS1 PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 janv. 2012

    État du capital au 09 janv. 2012

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Phillip Simpson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Dean Atkin en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sfm Directors Limited le 11 janv. 2010

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sfm Directors (No.2) Limited le 11 janv. 2010

    2 pagesCH02

    Nomination de Vinoy Nursiah en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jefrey Lundgren en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    13 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    16 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    Qui sont les dirigeants de RMAC 2002-NS1 PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ATKIN, Dean
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    Secrétaire
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    154553660001
    NURSIAH, Vinoy Rajanah
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    Administrateur
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector Of Client Accounting & Finance165402030001
    SFM DIRECTORS (NO.2) LIMITED
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    Administrateur
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04017430
    71663610002
    SFM DIRECTORS LIMITED
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    Administrateur
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03920254
    69353890002
    EDMONDS, Karen Britt
    Badgers Barn
    Farthings Paddock
    BA7 7QA Alford
    Somerset
    Secrétaire
    Badgers Barn
    Farthings Paddock
    BA7 7QA Alford
    Somerset
    British42484650004
    SIMPSON, Phillip Bertram
    16 Gatscombe Crescent
    Hanover Park
    SL5 7HA Ascot
    Secrétaire
    16 Gatscombe Crescent
    Hanover Park
    SL5 7HA Ascot
    BritishSolicitor54705580002
    ACHESON, William Brian
    Eastern Gate
    Brants Bridge
    RG12 9BZ Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Eastern Gate
    Brants Bridge
    RG12 9BZ Bracknell
    Berkshire
    AmericanDirector100315920003
    BRADLEY, Colin Walter
    Williamsgate
    The Street
    RG27 0PJ Eversley
    Hampshire
    Administrateur
    Williamsgate
    The Street
    RG27 0PJ Eversley
    Hampshire
    BritishDirector Of Finance70001440003
    HIGGINS, Christopher James
    24 Ennismore Avenue
    GU1 1SR Guildford
    Surrey
    Administrateur
    24 Ennismore Avenue
    GU1 1SR Guildford
    Surrey
    BritishFinance Director115417740001
    LUNDGREN, Jefrey Andrew
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector130391340002

    RMAC 2002-NS1 PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of amendment
    Créé le 30 sept. 2005
    Livré le 17 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the issuer to the trustee and/or any receiver and to ambac and to each of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed security with full title guarantee all right title interest and benefit in the english mortgage loans and the english mortgages in the mortgage pool and the title deeds and documents relating to the property in england and wales. All right title and interest in the scottish trust property, the northern irish mortgage loans, the charged obligation documents, floating chargeall undertaking property and assets present and future,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Chase Bank Manhattan, National Association (Formerly J P Morgan Bank)
    Transactions
    • 17 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignation in security
    Créé le 30 avr. 2002
    Livré le 08 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the beneficial interest in the additional scottish trust property as defined in the supplemental declaration of trust. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jp Morgan Chase Bank (The Trustee) Which Expression Shall Include Such Company and All Other Persons or Companies for the Time Being Acting Under the Trust Deed or Under the Deed of Charge as Trustee
    Transactions
    • 08 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of charge and assignment
    Créé le 27 févr. 2002
    Livré le 08 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver and to ambac assurance UK limited ("ambac") and any other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    English mortgages, insurance contracts and other related security, scottish mortgages, scottish trust security, northern irish mortgages, contractual and other rights, bank accounts, authorised investments and further acquired items.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank (The "Trustee")
    Transactions
    • 08 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0