RMAC 2002-NS1 PLC
Vue d'ensemble
Nom de la société | RMAC 2002-NS1 PLC |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société anonyme cotée en bourse |
Numéro de société | 04349853 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RMAC 2002-NS1 PLC ?
Adresse du siège social | 5 Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell Berkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RMAC 2002-NS1 PLC ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour RMAC 2002-NS1 PLC ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Phillip Simpson en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Dean Atkin en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Sfm Directors Limited le 11 janv. 2010 | 2 pages | CH02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Sfm Directors (No.2) Limited le 11 janv. 2010 | 2 pages | CH02 | ||||||||||
Nomination de Vinoy Nursiah en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jefrey Lundgren en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2008 | 13 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 353 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
legacy | 1 pages | 190 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2007 | 16 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RMAC 2002-NS1 PLC ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATKIN, Dean | Secrétaire | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire | 154553660001 | |||||||||||
NURSIAH, Vinoy Rajanah | Administrateur | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire | United Kingdom | British | Director Of Client Accounting & Finance | 165402030001 | ||||||||
SFM DIRECTORS (NO.2) LIMITED | Administrateur | Great St Helen's EC3A 6AP London 35 |
| 71663610002 | ||||||||||
SFM DIRECTORS LIMITED | Administrateur | Great St Helen's EC3A 6AP London 35 |
| 69353890002 | ||||||||||
EDMONDS, Karen Britt | Secrétaire | Badgers Barn Farthings Paddock BA7 7QA Alford Somerset | British | 42484650004 | ||||||||||
SIMPSON, Phillip Bertram | Secrétaire | 16 Gatscombe Crescent Hanover Park SL5 7HA Ascot | British | Solicitor | 54705580002 | |||||||||
ACHESON, William Brian | Administrateur | Eastern Gate Brants Bridge RG12 9BZ Bracknell Berkshire | American | Director | 100315920003 | |||||||||
BRADLEY, Colin Walter | Administrateur | Williamsgate The Street RG27 0PJ Eversley Hampshire | British | Director Of Finance | 70001440003 | |||||||||
HIGGINS, Christopher James | Administrateur | 24 Ennismore Avenue GU1 1SR Guildford Surrey | British | Finance Director | 115417740001 | |||||||||
LUNDGREN, Jefrey Andrew | Administrateur | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 130391340002 |
RMAC 2002-NS1 PLC a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of amendment | Créé le 30 sept. 2005 Livré le 17 oct. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the issuer to the trustee and/or any receiver and to ambac and to each of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed security with full title guarantee all right title interest and benefit in the english mortgage loans and the english mortgages in the mortgage pool and the title deeds and documents relating to the property in england and wales. All right title and interest in the scottish trust property, the northern irish mortgage loans, the charged obligation documents, floating chargeall undertaking property and assets present and future,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignation in security | Créé le 30 avr. 2002 Livré le 08 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in and to the beneficial interest in the additional scottish trust property as defined in the supplemental declaration of trust. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of charge and assignment | Créé le 27 févr. 2002 Livré le 08 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver and to ambac assurance UK limited ("ambac") and any other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions English mortgages, insurance contracts and other related security, scottish mortgages, scottish trust security, northern irish mortgages, contractual and other rights, bank accounts, authorised investments and further acquired items.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0