EMPIRE REALISATIONS (5) LIMITED

EMPIRE REALISATIONS (5) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEMPIRE REALISATIONS (5) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04354868
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EMPIRE REALISATIONS (5) LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe EMPIRE REALISATIONS (5) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EMPIRE REALISATIONS (5) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALLINGTON COMMUNICATIONS LIMITED17 janv. 200217 janv. 2002

    Quels sont les derniers comptes de EMPIRE REALISATIONS (5) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour EMPIRE REALISATIONS (5) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 02 févr. 2011

    24 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 02 août 2010

    17 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 02 févr. 2010

    23 pages2.24B

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 févr. 2010

    État du capital au 03 févr. 2010

    • Capital: GBP 25,775
    SH01

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    69 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed allington communications LIMITED\certificate issued on 06/08/09
    2 pagesCERTNM

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    12 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    11 pages155(6)b

    legacy

    11 pages155(6)b

    legacy

    11 pages155(6)b

    legacy

    11 pages155(6)b

    legacy

    11 pages155(6)b

    legacy

    12 pages395

    legacy

    7 pages395

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Loan/beb agrmnt aprvd 19/11/07
    RES13

    Qui sont les dirigeants de EMPIRE REALISATIONS (5) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, Nicholas John
    South Parade
    YO23 1BF York
    7
    North Yorkshire
    Secrétaire
    South Parade
    YO23 1BF York
    7
    North Yorkshire
    BritishDirector130606790001
    WILLIAMS, Nicholas John
    South Parade
    YO23 1BF York
    7
    North Yorkshire
    Administrateur
    South Parade
    YO23 1BF York
    7
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector130606790001
    FLACK, Derek Edward
    3 Fairview Drive
    WD17 4ST Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    3 Fairview Drive
    WD17 4ST Watford
    Hertfordshire
    BritishAccountant64927390001
    HUDSON, Paul Andrew
    12 The Beeches
    LS22 6ST Wetherby
    West Yorkshire
    Secrétaire
    12 The Beeches
    LS22 6ST Wetherby
    West Yorkshire
    BritishFinance Director63303690001
    MARINO, Salvatore Peter Anthony
    13 Allington Road
    Hendon
    NW4 3EA London
    Secrétaire
    13 Allington Road
    Hendon
    NW4 3EA London
    BritishCompany Director7770200002
    CARFAX CORPORATE SERVICES LIMITED
    116 St Aldates
    OX1 1HA Oxford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    116 St Aldates
    OX1 1HA Oxford
    Oxfordshire
    79236050001
    FLACK, Derek Edward
    3 Fairview Drive
    WD17 4ST Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Fairview Drive
    WD17 4ST Watford
    Hertfordshire
    BritishAccountant64927390001
    HUDSON, Paul Andrew
    12 The Beeches
    LS22 6ST Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    12 The Beeches
    LS22 6ST Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director63303690001
    JAGUSZ, Christopher
    16 Hampden Hill
    HP9 1BP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    16 Hampden Hill
    HP9 1BP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector116115660001
    MARINO, Paolo Pietro Antonio
    72 Christchurch Avenue
    NW6 7PE London
    Administrateur
    72 Christchurch Avenue
    NW6 7PE London
    BritishCompany Director21984810001
    MARINO, Salvatore Peter Anthony
    13 Allington Road
    Hendon
    NW4 3EA London
    Administrateur
    13 Allington Road
    Hendon
    NW4 3EA London
    EnglandBritishCompany Director7770200002
    OXFORD NOMINEES LIMITED
    116 St Aldates
    OX1 1HA Oxford
    Administrateur
    116 St Aldates
    OX1 1HA Oxford
    97875740001

    EMPIRE REALISATIONS (5) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Master guarantee and security agreement
    Créé le 20 nov. 2007
    Livré le 29 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become from belle bidco limited and/or each guarantor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Inflexion Private Equity Partners LLP (Security Trustee)
    Transactions
    • 29 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    All monies debenture
    Créé le 20 nov. 2007
    Livré le 28 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 10 juil. 2007
    Livré le 18 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of covenant
    Créé le 27 juin 2002
    Livré le 29 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Each receivables account in to which dividends and management charges are payable by service direct (UK) PLC and other subsidiaries of the company and any loans thereby pursuant to a deed of covenant dated 27/6/2002. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 29 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over deposits
    Créé le 27 juin 2002
    Livré le 29 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A first fixed charge over any sums deposited in any deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 29 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    EMPIRE REALISATIONS (5) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 août 2009Administration started
    02 févr. 2011Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Ian Brown
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    practitioner
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0