GREEN BIOLOGICS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GREEN BIOLOGICS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04358718 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GREEN BIOLOGICS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Thatched House High Street Wargrave RG10 8JA Reading Berkshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GREEN BIOLOGICS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour GREEN BIOLOGICS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 23 janv. 2025 |
Quels sont les derniers dépôts pour GREEN BIOLOGICS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2025 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 janv. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2024 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2023 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 154Ah Brook Drive Milton Park Abingdon Oxon OX14 4SD England à Thatched House High Street Wargrave Reading Berkshire RG10 8JA le 13 mars 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 janv. 2024 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed biocleave LIMITED\certificate issued on 14/08/23 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2022 | 27 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 janv. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2021 | 32 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 janv. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 30 juin 2020 | 51 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 janv. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Tamsin Denise Crane en tant que directeur le 14 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 30 juin 2019 | 53 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 janv. 2020 avec mises à jour | 10 pages | CS01 | ||||||||||||||
Statuts | 30 pages | MA | ||||||||||||||
Annulation d'actions. État du capital au 09 nov. 2018
| 5 pages | SH06 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Annulation d'actions. État du capital au 26 sept. 2019
| 5 pages | SH06 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 30 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de GREEN BIOLOGICS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENKINSON, Elizabeth Rachael, Dr | Administrateur | High Street Wargrave RG10 8JA Reading Thatched House Berkshire England | England | British | 262847120001 | |||||
| STANLEY, Karen Elizabeth | Administrateur | High Street Wargrave RG10 8JA Reading Thatched House Berkshire England | United Kingdom | British | 212405580001 | |||||
| SUTCLIFFE, Sean George Cronin | Administrateur | 1 High Street Wargrave RG1O 8JA Reading Thatched House | England | British | 73301090002 | |||||
| MAILLARD, Karine Isabelle | Secrétaire | Flat 1 West Grange Main Road East Hagbourne OX11 9LJ Didcot Oxfordshire | French | 97198070001 | ||||||
| SWEENEY, Christina Margaret | Secrétaire | 6 Main Road East Hagbourne OX11 9LJ Didcot Oxfordshire | British | 78391340001 | ||||||
| WESSELBAUM, Judith Anne | Secrétaire | 5 Spenser Close OX26 2FA Bicester Oxfordshire | British | 105561980001 | ||||||
| ASHLEY SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Ashley House 5 Grosvenor Square SO15 2BE Southampton Hampshire | 34342460005 | |||||||
| BLAIR, Martin Incledon | Administrateur | Brook Drive Milton Park OX14 4SD Abingdon 154ah Oxon England | England | British | 68265660001 | |||||
| BRISTER, David John | Administrateur | c/o Oxford Capital Partners Cumnor Hill OX2 9PJ Oxford 201 Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 134584510001 | |||||
| CHAN, Gerald | Administrateur | 1188 Centre Street Newton Centre 02459 Ma Usa | United States | American | 134647220001 | |||||
| CHRISTOU, Victor, Dr. | Administrateur | 45a Milton Park Abingdon OX14 4RU Oxfordshire | United Kingdom | British | 111422620002 | |||||
| CHRISTOU, Victor, Dr. | Administrateur | Warwick Close OX14 2HN Abingdon 10 Oxfordshire | United Kingdom | British | 111422620002 | |||||
| CRANE, Tamsin Denise | Administrateur | Brook Drive Milton Park OX14 4SD Abingdon 154ah Oxon England | England | British | 262848030001 | |||||
| CUBBON, Martin | Administrateur | Brook Drive Milton Park OX14 4SD Abingdon 154ah Oxon England | Isle Of Man | British | 252311330001 | |||||
| DAVIES, Edward Timothy, Dr | Administrateur | 360 Brickleberry Ridge 30605 Athens Georgia Usa | Usa | British | 103329330001 | |||||
| GREEN, Edward Mcconachie, Dr | Administrateur | 8 Vansittart Road Bisham SL7 1RU Marlow Buckinghamshire | England | British | 87319520002 | |||||
| GROTE, Thomas James, Chief Financial Officer | Administrateur | Jaeger Street 43206 Columbus 982 Ohio Usa | Usa | Usa | 165883020001 | |||||
| HENSON, Paul Robert | Administrateur | Brook Drive Milton Park OX14 4SD Abingdon 154ah Oxon England | England | British | 171759580002 | |||||
| HOHMAN, James Joseph, Mr. | Administrateur | Brook Drive Milton Park OX14 4SD Abingdon 154ah Oxon England | United States | American | 195233730001 | |||||
| JONES, Simon | Administrateur | 37 Midwinter Avenue Milton Heights OX14 4XB Abingdon Oxfordshire | England | British | 80702850001 | |||||
| LACAMP, Philippe Paul, Mr. | Administrateur | One Pacific Place 88 Queensway 33/F Hong Kong | Hong Kong | British | 183815700001 | |||||
| LEUNG, Man Ching Maggie, Ms. | Administrateur | 33/F One Pacific Place 88 Queensway Hong Kong Swire Pacific Limited Hong Kong | Hong Kong | British | 199388460001 | |||||
| LUCQUIN, Denis Jacques, Mr. | Administrateur | c/o Sofinnova Partners Rue Du Septembre 75002 Paris 18 France | France | French | 183812340001 | |||||
| MANSFIELD, Simon Iliff, Mr. | Administrateur | Western Avenue Milton Park OX14 4RU Abingdon 45a Oxfordshire United Kingdom | England | British | 177637430001 | |||||
| MARSH, John Richard, Dr | Administrateur | Cumnor Hil OX2 9PJ Oxford 201 Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 136128200001 | |||||
| MCCARTHY, Reenie (Irene), Ms. | Administrateur | Centre Street 02459 Newton 1188 Massachusetts Usa | Usa Massachusetts | American | 152638860001 | |||||
| PRITCHARD, Brad | Administrateur | Brook Drive Milton Park OX14 4SD Abingdon 154ah Oxon England | United States | American | 251583380001 | |||||
| RAE-SMITH, John Bruce | Administrateur | Brook Drive Milton Park OX14 4SD Abingdon 154ah Oxon England | United Kingdom | British | 135359240003 | |||||
| REED, Keon Alexander | Administrateur | Brook Drive Milton Park OX14 4SD Abingdon 154ah Oxon England | United States | American | 251583540001 | |||||
| RICKMAN, Andrew George, Dr | Administrateur | Rockley Manor Rockley SN8 1RT Marlborough Wiltshire | England | British | 100476390001 | |||||
| STONE, Joel Arthur | Administrateur | Montfort Circle 23059 Glen Allen 11919 Va Usa | Usa | Usa | 165883290001 | |||||
| STOUFS, Claude Jules Nestor, Mr. | Administrateur | c/o Capricorn Venture Partners Lei B-3000 Leuven 19/1 Belgium | Belgium | Belgian | 152022980001 | |||||
| TURNER, Simon Patrick David Hart Lucas, Dr | Administrateur | Clifford Manor Road GU4 8AG Guildford 18 Surrey | United Kingdom | British | 137989590001 | |||||
| WITT, Mark Noel, Mr. | Administrateur | N Barkers Landing Road 77079 Houston 15910 Texas Usa | Usa | American | 199389150001 | |||||
| ASHLEY DIRECTORS LIMITED | Administrateur | Ashley House 5 Grosvenor Square SO15 2BE Southampton Hampshire | 65926830002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GREEN BIOLOGICS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Elizabeth Rachael Jenkinson | 26 sept. 2019 | High Street Wargrave RG10 8JA Reading Thatched House Berkshire England | Non | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Cell Energy Limited | 06 avr. 2016 | West Bay Road The Offices Of Offshore Incorporations(Cayman) Ltd POBOX31119 Grand Cayman Ky1-1205 802 Cayman Islands | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| John Swire & Sons Limited | 06 avr. 2016 | Buckingham Gate SW1E 6AJ London Swire House 59 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0