LILAC HOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLILAC HOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04360430
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LILAC HOMES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe LILAC HOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Suffolk Way
    TN13 1YL Sevenoaks
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LILAC HOMES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ASHLEY 033 LIMITED25 janv. 200225 janv. 2002

    Quels sont les derniers comptes de LILAC HOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LILAC HOMES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour LILAC HOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 janv. 2016

    État du capital au 27 janv. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2014

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 févr. 2015

    État du capital au 27 févr. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 févr. 2014

    État du capital au 06 févr. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2013

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Brebners Tubs Hill House London Road Sevenoaks Kent TN13 1BL* le 24 avr. 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2012

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2010

    4 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Aidan Victor Cogley le 25 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Declan Aidan Cogley le 25 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages225

    Qui sont les dirigeants de LILAC HOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COGLEY, Declan Aidan
    1 Sycamore Gardens
    Paddock Wood
    TN12 6LJ Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    1 Sycamore Gardens
    Paddock Wood
    TN12 6LJ Tonbridge
    Kent
    EnglishSurveyor80639400001
    COGLEY, Aidan Victor
    Glenbough
    Screen
    Enniscorthy
    County Wexford
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    Glenbough
    Screen
    Enniscorthy
    County Wexford
    Republic Of Ireland
    United KingdomBritishContracts Director80639850002
    COGLEY, Declan Aidan
    1 Sycamore Gardens
    Paddock Wood
    TN12 6LJ Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    1 Sycamore Gardens
    Paddock Wood
    TN12 6LJ Tonbridge
    Kent
    EnglandEnglishSurveyor80639400001
    COURTNAGE, Angela Jean
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    Secrétaire désigné
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    British900023240001
    TAYLOR, Martyn Paul Ashley
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    Administrateur désigné
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    British900023250001

    LILAC HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 14 oct. 2005
    Livré le 25 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at victoria works, victoria road, golden green, tonbridge, kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 12 oct. 2005
    Livré le 13 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land at mill house mark cross crowborough east sussex.
    Personnes ayant droit
    • Derek Holland and June Rosemary Holland
    Transactions
    • 13 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 12 oct. 2005
    Livré le 13 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjacent to mill house mark cross rotherfield east sussex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 2003
    Livré le 07 août 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The toy factory third street speldhurst tunbridge wells kent t/no: K361314. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 2003
    Livré le 21 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0