TRADEFULL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRADEFULL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04365878
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRADEFULL LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe TRADEFULL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TRADEFULL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour TRADEFULL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    31 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    24 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    4 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    26 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 janv. 2017

    22 pages2.24B

    Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Pricewaterhousecoopers Llp Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP à Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL le 03 janv. 2017

    2 pagesAD01

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 juil. 2016

    24 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 janv. 2016

    24 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 juil. 2015

    26 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 janv. 2015

    26 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 juil. 2014

    28 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 juil. 2014

    28 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 09 févr. 2014

    29 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 sept. 2013

    25 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    5 pages2.16B

    Résultat de la réunion des créanciers

    2 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    42 pages2.17B

    Qui sont les dirigeants de TRADEFULL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Secrétaire
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    DUNCAN, Gavin Robert
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Administrateur
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    EnglandBritish151512820001
    MELLOR, Craig Allan
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Administrateur
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    EnglandBritish60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    DEXTER, Graeme Peter Andrew
    72 Gorwel
    LL33 0DT Llanfairfechan
    Gwynedd
    Secrétaire
    72 Gorwel
    LL33 0DT Llanfairfechan
    Gwynedd
    British76695610001
    WILKINSON, Christopher John
    46 Grange Road
    Bowdon
    WA14 3EY Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    46 Grange Road
    Bowdon
    WA14 3EY Altrincham
    Cheshire
    British90439130001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BULLIVANT, Peter Wild
    Tudor Farm
    Kinnerton Road Dodleston
    CH4 9LP Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Tudor Farm
    Kinnerton Road Dodleston
    CH4 9LP Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish50290920002
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    SMITH, David Ryder
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    Administrateur
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    EnglandBritish202067380001
    WATKIN JONES, Glyn
    Y Glyn
    Holyhead Road
    LL57 2HX Bangor
    Gwynedd
    Administrateur
    Y Glyn
    Holyhead Road
    LL57 2HX Bangor
    Gwynedd
    WalesWelsh77892600001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    TRADEFULL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 mai 2011
    Livré le 09 juin 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 09 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 31 mai 2011
    Livré le 04 juin 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    7 wilmslow road rusholme manchester t/no GM647799 all buildings erections fixtures including trade fixtures and fixed plant and machinery at any time thereon see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 04 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal mortgage
    Créé le 01 mars 2006
    Livré le 03 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h land and premises being 7 wilmslow road rusholme t/n GM647799. By way of assignment the rental income and the benefit of the company aof all other rights and claims to which the company is now or may in the future become entitled in. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited A.B.N 12004044937
    Transactions
    • 03 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 mars 2006
    Livré le 03 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by the company to the chargee (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited A.B.N 12004 044937
    Transactions
    • 03 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over deposit account
    Créé le 31 déc. 2003
    Livré le 13 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all monies standing to the credit of the sterling account numbered 01590707.
    Personnes ayant droit
    • Ahli United Bank (UK) PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 nov. 2002
    Livré le 22 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 22 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 19 nov. 2002
    Livré le 22 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/Hold land and premises being 7 wilmslow rd,rusholme; GM647799; all rights powers easements and liberties with all buildings,fixtures,fittings,plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 22 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    TRADEFULL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 sept. 2018Administration ended
    14 mars 2013Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    David James Kelly
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    practitioner
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Toby Scott Underwood
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    practitioner
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0