365 IT SUBCO NO.1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la société365 IT SUBCO NO.1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04366702
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Napoleon House Riseley Business Park, Basingstoke Road
    Riseley
    RG7 1NW Reading
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    5I LIMITED05 févr. 200205 févr. 2002

    Quels sont les derniers comptes de 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 avr. 2012

    État du capital au 12 avr. 2012

    • Capital: GBP 120,762.69
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 4 Cartel Business Centre Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW le 10 avr. 2012

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Peter Maclean en tant que directeur le 22 sept. 2011

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed 5I LIMITED\certificate issued on 01/12/11
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Transfer share cap 22/09/2011
    RES13

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2010 au 30 juin 2011

    1 pagesAA01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Nomination de Mb Secretaries Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Alastair Ferguson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Alastair Ferguson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    16 pagesAA

    Nomination de Mr Alastair William Ferguson en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Hearn en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de David Hearn en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Alastair William Ferguson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    5 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    12 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gareth Hearn le 05 févr. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MB SECRETARIES LIMITED
    The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement4813248
    124285230001
    ALLAN, Keith Andrew
    16 Sovereign Close
    CV8 1SQ Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    16 Sovereign Close
    CV8 1SQ Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritish100161360001
    BROWN, Richard William
    24a Alma Road
    SL4 3HL Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    24a Alma Road
    SL4 3HL Windsor
    Berkshire
    EnglandBritish100161150001
    HOWELLS, Peter Hugh
    Centurion House
    11 Romans Field,
    RG7 2QH Silchester
    Berkshire
    Administrateur
    Centurion House
    11 Romans Field,
    RG7 2QH Silchester
    Berkshire
    EnglandBritish163030330001
    FERGUSON, Alastair William
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    Secrétaire
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    154526830001
    HEARN, David Gareth
    Middle Prospect New Road
    OX18 2LF Bampton
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Middle Prospect New Road
    OX18 2LF Bampton
    Oxfordshire
    British59462210001
    ORCHARD, Clive
    Birchtree Cottages
    Kings Road Silchester
    RG7 2NT Reading
    2
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Birchtree Cottages
    Kings Road Silchester
    RG7 2NT Reading
    2
    Berkshire
    United Kingdom
    British81052720003
    BOYES TURNER SECRETARIES LIMITED
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    74407280002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FERGUSON, Alastair William
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    Administrateur
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    EnglandBritish125179970001
    HEARN, David Gareth
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    Administrateur
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    United KingdomBritish59462210001
    MACLEAN, Peter
    Steventon Manor
    RG25 3BE Steventon
    Hampshire
    Administrateur
    Steventon Manor
    RG25 3BE Steventon
    Hampshire
    United KingdomBritish157773140001
    ORCHARD, Clive
    47 Jubilee Close
    Pamber Heath
    RG26 3HP Tadley
    Hampshire
    Administrateur
    47 Jubilee Close
    Pamber Heath
    RG26 3HP Tadley
    Hampshire
    British81052720002
    RANSOM, Graham Richard
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    UkBritish34690210001
    STEVENS, Terrence
    17 Elliott Rise
    SL5 8NN North Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    17 Elliott Rise
    SL5 8NN North Ascot
    Berkshire
    British81052700001
    BOYES TURNER DIRECTORS LIMITED
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Administrateur
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    101374610001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    365 IT SUBCO NO.1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 28 avr. 2010
    Livré le 29 avr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies from time to time standing to the credit of the interest bearing deposit account operated by field seymour parks as solicitors for the landlord under the lease pursuant to the terms of the said rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Mulhern Properties Limited
    Transactions
    • 29 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Fixed and floating charge
    Créé le 30 nov. 2007
    Livré le 08 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 08 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2006
    Livré le 19 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 08 mai 2006
    Livré le 09 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies from time to time standing to the credit of the interest-bearing deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Mulhern Properties Limited
    Transactions
    • 09 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 févr. 2005
    Livré le 22 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC Trading as Venture Factors
    Transactions
    • 22 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental deposit deed
    Créé le 08 avr. 2004
    Livré le 23 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies from time to time standing to the credit of the interest bearing deposit account pursuant to the terms of the rental deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Mulhern Properties Limited
    Transactions
    • 23 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 17 juil. 2002
    Livré le 23 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £6,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The sum of £6,750.00.
    Personnes ayant droit
    • Daceberry Limited
    Transactions
    • 23 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0