GRACE FILMS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | GRACE FILMS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04375471 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GRACE FILMS LIMITED ?
Adresse du siège social | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GRACE FILMS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour GRACE FILMS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 11 pages | AA | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 févr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 févr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 févr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Carmel Michelle Burke en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Carmel Michelle Burke en tant qu'administrateur le 23 janv. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Julian Garner Freeston en tant que directeur le 31 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Peter Langenberg en tant qu'administrateur le 01 nov. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Roderick Waldemar Lisle Henwood en tant que directeur le 01 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 14 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Julian Garner Freeston le 29 juil. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Roderick Waldemar Lisle Henwood en tant qu'administrateur le 01 sept. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Marc-Antoine D'halluin en tant que directeur le 01 sept. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tim David Breadin en tant que directeur le 23 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GRACE FILMS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBOUR, Hamish Macvinish | Administrateur | 14a Hatfield Drive G12 0YA Glasgow | Scotland | British | Creative Director | 35392400001 | ||||
BURKE, Carmel Michelle | Administrateur | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | United Kingdom | Irish | Director | 224677940001 | ||||
GREGSON, Sarah Jane | Administrateur | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | United Kingdom | British | Director | 29602640002 | ||||
LANGENBERG, Peter | Administrateur | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | United Kingdom | Dutch | Director | 222055210001 | ||||
CLEMENTS, Alan | Secrétaire | 4 Cleveden Crescent G12 0PD Glasgow | British | Producer | 39073520002 | |||||
FREESTON, Julian Garner | Secrétaire | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | 153183260001 | |||||||
MORRIS, Jillian Margaret | Secrétaire | 65a Gardner Street G11 5BZ Glasgow Scotland | British | Company Secretary | 51288960001 | |||||
SLOW, Jonathan Mark | Secrétaire | Brussels Road SW1 1UK London 8 | British | 138550940001 | ||||||
SMITH, David William | Secrétaire | 15 Caiystane Terrace EH10 6SR Edinburgh Midlothian | British | Solicitor | 106115680001 | |||||
TM COMPANY SERVICES LIMITED | Secrétaire | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 37914570001 | |||||||
BREADIN, Tim David | Administrateur | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | England | British | Director | 177047460001 | ||||
CLEMENTS, Alan | Administrateur | 4 Cleveden Crescent G12 0PD Glasgow | United Kingdom | British | Producer | 39073520002 | ||||
D'HALLUIN, Marc-Antoine | Administrateur | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | England | French | Director | 172359320001 | ||||
FETHER, Joely Bryn | Administrateur | Archibald Road N7 0AN London 27 England | England | British | Director | 42885320005 | ||||
FRANK, David Vincent Mutrie | Administrateur | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | England | British | Director | 152744230001 | ||||
FRANK, David Vincent Mutrie | Administrateur | Ruvigny Gardens SW15 1JR London 9 United Kingdom | England | British | Director | 152744230001 | ||||
FREESTON, Julian Garner | Administrateur | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | England | British | Director | 153176720001 | ||||
FREESTON, Julian Garner | Administrateur | Robin Hill Drive BR7 5ER Chislehurst 7 Kent England | England | British | Director | 153176720001 | ||||
HENWOOD, Roderick Waldemar Lisle | Administrateur | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | England | British | Director | 191508930001 | ||||
ORIEL, Susan Margaret Julie | Administrateur | 21 Clancarty Road SW6 3AH London | Uk | British | Company Director | 125403860001 | ||||
PRICE, Janice Lynne | Administrateur | 45 Southdean Gardens SW19 6NT London | British | Finance Director | 55643820003 | |||||
QUINN, Eileen | Administrateur | 19 Oakhill Place Oakhill Road SW15 2QN Putney London | American | Producer | 33130440002 | |||||
ROGERS, Mark Ian James | Administrateur | Kew Road TW9 3EB Richmond 36 Christopher Court Surrey England | United Kingdom | British | Lawyer | 93338140001 | ||||
SLOW, Jonathan Mark | Administrateur | Brussels Road SW11 2AF London 8 | United Kingdom | British | Director | 108443110002 | ||||
REYNARD NOMINEES LIMITED | Administrateur | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 40850920001 | |||||||
TM COMPANY SERVICES LIMITED | Administrateur | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 37914570001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GRACE FILMS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monogram Productions Limited | 06 avr. 2016 | Kensington Village Avonmore Road W14 8RF London Gloucester Building England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
GRACE FILMS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge and security assignment | Créé le 16 oct. 2008 Livré le 21 oct. 2008 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Assigns all preprint elements, positive prints, soundtrack elements, literary property, copyright, music and musical compositions, contracts, sequels see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge (with effect as of 6 december 2002) over the programme provisionally entitled "saving grace" | Créé le 13 déc. 2002 Livré le 19 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Right title and interest in and to the rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over cash deposit and account | Créé le 06 déc. 2002 Livré le 19 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge the deposit and the debts represented by the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge on deposits | Créé le 06 déc. 2002 Livré le 18 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The sum of gbp 1,734,234.22 deposited by the company in account number 4.01.39.220 gbp. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 juin 2002 Livré le 26 juin 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 28 mai 2002 Livré le 08 juin 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from bentley productions limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of assignment the borrower's right, title and interest in and to the rights, the itv contract, the benefit of the insurance policies. By way of fixed charge the borrower's right, title and interest in and to the programme, the proceeds of the insurance policies and all sums in the borrowers current account. By way of floating charge any and all of the borrower's rights in and to the above to the extent they fail to operate as a fixed charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0