NLDSN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNLDSN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04379849
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NLDSN LIMITED ?

    • Commerce de gros de vêtements et de chaussures (46420) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Commerce de gros non spécialisé (46900) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe NLDSN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Two Snowhill
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NLDSN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LLC LIMITED22 févr. 200222 févr. 2002

    Quels sont les derniers comptes de NLDSN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour NLDSN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    16 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 janv. 2018

    14 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Bear House Concorde Way Fareham Hampshire PO15 5RL à Two Snowhill Two Snowhill Birmingham B4 6GA le 20 févr. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 janv. 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Certificat de changement de nom

    Company name changed llc LIMITED\certificate issued on 19/12/16
    3 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mars 2016

    État du capital au 08 mars 2016

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 mars 2015

    État du capital au 06 mars 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    21 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 mars 2014

    État du capital au 21 mars 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    20 pagesAA

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    6 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mrs Anna Eva Viktoria Williams en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Dr Johan Esbjorn Patrick Waktare en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de NLDSN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WAKTARE, Nils Bjorn Oskar
    3 Chilworth Grange
    Chilworth
    SO16 7QH Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    3 Chilworth Grange
    Chilworth
    SO16 7QH Southampton
    Hampshire
    British57811570006
    WAKTARE, Johan Esbjorn Patrick, Dr
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    Administrateur
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    EnglandSwedishDoctor10572300009
    WAKTARE, Karl Styrbjorn
    Conal House
    Chapel Road
    SO32 3NJ Meonstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Conal House
    Chapel Road
    SO32 3NJ Meonstoke
    Hampshire
    United KingdomSwedishManaging Director44084840003
    WAKTARE, Nils Bjorn Oskar
    3 Chilworth Grange
    Chilworth
    SO16 7QH Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    3 Chilworth Grange
    Chilworth
    SO16 7QH Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishDirector57811570006
    WILLIAMS, Andrew
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    Administrateur
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    EnglandBritishSales Director150034030001
    WILLIAMS, Anna Eva Viktoria
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    Administrateur
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    EnglandBritishCompany Director174329400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DENIS, Nevoret
    22 Chemin Des Landres
    Ternay
    69360
    France
    Administrateur
    22 Chemin Des Landres
    Ternay
    69360
    France
    FrenchChief Financial Officer109835820001
    JOFFARD, Philippe
    27 Rue Des Sablons
    75115
    Paris
    France
    Administrateur
    27 Rue Des Sablons
    75115
    Paris
    France
    FrenchChairman & Managing Director80456230001
    RIGOULET, Jean-Paul Gerard
    582 Route Des Condamines
    Vernaison 69390
    France
    Administrateur
    582 Route Des Condamines
    Vernaison 69390
    France
    FrenchInternational Manager80456220001

    NLDSN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 18 mars 2013
    Livré le 03 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a bear house and unit 1 concorde way segensworth north winchester t/n HP600420 any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 mars 2013
    Livré le 21 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 12 mars 2012
    Livré le 15 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Distribution Finance Europe Limited
    Transactions
    • 15 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 24 juin 2009
    Livré le 08 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 08 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    NLDSN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 janv. 2017Commencement of winding up
    02 juin 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    practitioner
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0