ELANDOME LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéELANDOME LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04400336
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ELANDOME LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières
    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe ELANDOME LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suite 1, 3rd Floor 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ELANDOME LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour ELANDOME LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2021

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2020

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Macroberts Corporate Services Limited en tant que secrétaire le 01 mai 2020

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2018

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 044003360014 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 044003360009 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 044003360013 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2017

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 21 st Thomas Street Bristol BS1 6JS à Suite 1, 3rd Floor 11-12 st James's Square London SW1Y 4LB le 15 sept. 2017

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 21 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 janv. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 avr. 2016

    État du capital au 07 avr. 2016

    • Capital: GBP 23,853,720
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 janv. 2015

    7 pagesAA

    Satisfaction de la charge 044003360010 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 044003360012 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 044003360011 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de ELANDOME LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WHEATLEY, Douglas Gordon George
    Toran M'Or, Garngaber Avenue
    Lenzie,
    G66 4LJ Glasgow
    Administrateur
    Toran M'Or, Garngaber Avenue
    Lenzie,
    G66 4LJ Glasgow
    United KingdomBritish73814720001
    SHAH, Jinal Hasmukh
    22 Barton Road
    LU3 2BB Luton
    Bedfordshire
    Secrétaire
    22 Barton Road
    LU3 2BB Luton
    Bedfordshire
    British81330960001
    WHEATLEY, Douglas Gordon George
    Toran M'Or, Garngaber Avenue
    Lenzie,
    G66 4LJ Glasgow
    Secrétaire
    Toran M'Or, Garngaber Avenue
    Lenzie,
    G66 4LJ Glasgow
    British73814720001
    AUB SECRETARIES LIMITED
    7 Baker Street
    W1U 8EG London
    Secrétaire
    7 Baker Street
    W1U 8EG London
    58850600003
    BURNESS PAULL & WILLIAMSONS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    Numéro d'enregistrementSO300380
    99448920002
    MACROBERTS CORPORATE SERVICES LIMITED
    60 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Capella Building (Tenth Building)
    Scotland
    Secrétaire
    60 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Capella Building (Tenth Building)
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC177032
    130204580001
    SDG SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023580001
    SEATON, Stuart Neil
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Administrateur
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    EnglandBritish43505420002
    AUB SECRETARIES LIMITED
    7 Baker Street
    W1U 8EG London
    Administrateur
    7 Baker Street
    W1U 8EG London
    58850600003
    SDG REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023570001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ELANDOME LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Grandyard Limited
    St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    21
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    21
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk Companies Registry
    Numéro d'enregistrement04393442
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ELANDOME LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2013
    Livré le 23 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Subjects known as new cross shopping centre, hamilton t/no LAN80445. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2013
    Livré le 23 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The subjects known as granite house, glasgow and subjects on the north and east side of osborne street, glasgow t/nos GLA67288, GLA100737, GLA102467, GLA130228, GLA79494, GLA106909 and GLA112791. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 déc. 2013
    Livré le 23 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 déc. 2013
    Livré le 23 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 déc. 2013
    Livré le 23 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 déc. 2013
    Livré le 17 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 17 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 2ND september 2005 and
    Créé le 16 août 2005
    Livré le 13 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All and whole the tenant's interest in the lease of an area of ground at lamb street hamilton t/n LAN80445.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 16 août 2005
    Livré le 26 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings k/a tynedale house 134 cowley road oxford f/h t/no ON195154. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 03RD may 2002 and
    Créé le 16 avr. 2002
    Livré le 21 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a forming new cross shopping centre quarry place hamilton.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 03RD may 2002 and
    Créé le 16 avr. 2002
    Livré le 21 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a and forming granite house stockwell street glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 3RD may 2002
    Créé le 16 avr. 2002
    Livré le 18 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Granite house stockwell street glasgow. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 18 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 3RD may 2002
    Créé le 16 avr. 2002
    Livré le 18 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The subjects k/a and forming new cross shopping centre quarry place hamilton t/no: LAN80445.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 18 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party guarantee and debenture
    Créé le 16 avr. 2002
    Livré le 26 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and any group company (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 avr. 2002
    Livré le 23 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 23 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0