ELANDOME LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ELANDOME LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04400336 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ELANDOME LIMITED ?
| Adresse du siège social | Suite 1, 3rd Floor 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ELANDOME LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 janv. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour ELANDOME LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2021 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2020 | 8 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Macroberts Corporate Services Limited en tant que secrétaire le 01 mai 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2019 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2018 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 044003360014 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 044003360009 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 044003360013 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 21 st Thomas Street Bristol BS1 6JS à Suite 1, 3rd Floor 11-12 st James's Square London SW1Y 4LB le 15 sept. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 janv. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 janv. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 044003360010 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 044003360012 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 044003360011 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ELANDOME LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEATLEY, Douglas Gordon George | Administrateur | Toran M'Or, Garngaber Avenue Lenzie, G66 4LJ Glasgow | United Kingdom | British | 73814720001 | |||||||||||||
| SHAH, Jinal Hasmukh | Secrétaire | 22 Barton Road LU3 2BB Luton Bedfordshire | British | 81330960001 | ||||||||||||||
| WHEATLEY, Douglas Gordon George | Secrétaire | Toran M'Or, Garngaber Avenue Lenzie, G66 4LJ Glasgow | British | 73814720001 | ||||||||||||||
| AUB SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 7 Baker Street W1U 8EG London | 58850600003 | |||||||||||||||
| BURNESS PAULL & WILLIAMSONS LLP | Secrétaire | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh |
| 99448920002 | ||||||||||||||
| MACROBERTS CORPORATE SERVICES LIMITED | Secrétaire | 60 York Street G2 8JX Glasgow Capella Building (Tenth Building) Scotland |
| 130204580001 | ||||||||||||||
| SDG SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900023580001 | |||||||||||||||
| SEATON, Stuart Neil | Administrateur | 12 Priory Walk SW10 9SP London | England | British | 43505420002 | |||||||||||||
| AUB SECRETARIES LIMITED | Administrateur | 7 Baker Street W1U 8EG London | 58850600003 | |||||||||||||||
| SDG REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900023570001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ELANDOME LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandyard Limited | 06 avr. 2016 | St Thomas Street BS1 6JS Bristol 21 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
ELANDOME LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 17 déc. 2013 Livré le 23 déc. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Subjects known as new cross shopping centre, hamilton t/no LAN80445. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 17 déc. 2013 Livré le 23 déc. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description The subjects known as granite house, glasgow and subjects on the north and east side of osborne street, glasgow t/nos GLA67288, GLA100737, GLA102467, GLA130228, GLA79494, GLA106909 and GLA112791. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 13 déc. 2013 Livré le 23 déc. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description None. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Cr éé le 13 déc. 2013 Livré le 23 déc. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description None. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 13 déc. 2013 Livré le 23 déc. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 13 déc. 2013 Livré le 17 déc. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 2ND september 2005 and | Créé le 16 août 2005 Livré le 13 sept. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All and whole the tenant's interest in the lease of an area of ground at lamb street hamilton t/n LAN80445. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 16 août 2005 Livré le 26 août 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings k/a tynedale house 134 cowley road oxford f/h t/no ON195154. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 03RD may 2002 and | Créé le 16 avr. 2002 Livré le 21 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All and whole the subjects k/a forming new cross shopping centre quarry place hamilton. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 03RD may 2002 and | Créé le 16 avr. 2002 Livré le 21 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All and whole the subjects k/a and forming granite house stockwell street glasgow. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 3RD may 2002 | Créé le 16 avr. 2002 Livré le 18 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Granite house stockwell street glasgow. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 3RD may 2002 | Créé le 16 avr. 2002 Livré le 18 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The subjects k/a and forming new cross shopping centre quarry place hamilton t/no: LAN80445. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Third party guarantee and debenture | Créé le 16 avr. 2002 Livré le 26 avr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and any group company (as defined) to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 avr. 2002 Livré le 23 avr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0