DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04401640 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ?
| Adresse du siège social | 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 15 pages | LIQ13 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 déc. 2016 | 14 pages | 4.68 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT à 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place Southampton SO15 2BG le 05 déc. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 044016400008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 14 déc. 2015
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1st Floor 100 Wood Street London EC2V 7AN à Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT le 04 janv. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Martin John Trainer en tant que directeur le 14 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Charles Mills en tant que secrétaire le 14 déc. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Dermot James Joyce en tant que directeur le 14 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed trustmarque acquisitions LIMITED\certificate issued on 11/12/15 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de James Christopher Michael Woolley en tant que directeur le 03 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 14 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Neil Martin Simpson en tant que directeur le 26 mai 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divers Section 519 | 2 pages | MISC | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Dermot James Joyce le 11 sept. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Peter Charles Mills le 02 févr. 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Christopher Michael Woolley le 02 févr. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martin John Trainer le 02 févr. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Dermot James Joyce le 02 févr. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERGUSON, Paul John | Secrétaire | 31 Strensall Road Huntington YO32 9SH York North Yorkshire | British | 84739280002 | ||||||
| GODLIMAN, Victoria | Secrétaire | Triune Court Monks Cross Drive, Huntington YO32 9GZ York Trustmarque House Yorkshire England | 167818480001 | |||||||
| METCALFE, Richard Crosby, Mr. | Secrétaire | Ryehill Cottage Lyndhurst Road SO42 7YE Beaulieu Hampshire | British | 73646130001 | ||||||
| MILLS, Peter Charles | Secrétaire | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | 191202760001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| BLOW, Bridget Penelope | Administrateur | Flat 119 B Central 38 Paradise Street B1 2AF Birmingham West Midlands | England | British | 115125670001 | |||||
| COOKE, Ursula | Administrateur | 70 Bootham YO30 7DF York | British | 115125770002 | ||||||
| FERGUSON, Paul John | Administrateur | 31 Strensall Road Huntington YO32 9SH York North Yorkshire | England | British | 84739280002 | |||||
| FINLAYSON, David John Mcintosh | Administrateur | 8 Greenfields New Barn Lane Prestbury GL52 3LG Cheltenham Gloucestershire | British | 33124430005 | ||||||
| GODLIMAN, Victoria | Administrateur | Triune Court Monks Cross Drive, Huntington YO32 9GZ York Trustmarque House Yorkshire England | England | British | 83684440003 | |||||
| HADDOW, Scott William | Administrateur | Chelford Road WA16 8LY Knutsford Spinney End Cheshire United Kingdom | England | British | 121651070002 | |||||
| JOYCE, Dermot James | Administrateur | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | United Kingdom | Irish | 181301350001 | |||||
| LIGERTWOOD, Mark Murray | Administrateur | 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Saltire Court Midlothian Scotland | United Kingdom | Uk | 179214640001 | |||||
| LLOYD, Colin Thomas | Administrateur | Fawke Common Underriver TN15 0JX Sevenoaks Fawke House Kent | United Kingdom | British | 3616430001 | |||||
| METCALFE, Richard Crosby, Mr. | Administrateur | Ryehill Cottage Lyndhurst Road SO42 7YE Beaulieu Hampshire | United Kingdom | British | 73646130001 | |||||
| MILLER, Ross Charles | Administrateur | Primrose Farm Hagg Lane Dunnington YO19 5PE York Yorkshire | England | British | 84739210001 | |||||
| ROGERS, Christine Margaret | Administrateur | The Old Granary Chilton Road HP18 0DN Chearsley Buckinghamshire | United Kingdom | British | 66374680002 | |||||
| SIMPSON, Neil Martin | Administrateur | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | United Kingdom | British | 183192810001 | |||||
| TRAINER, Martin John | Administrateur | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | England | British | 124180840001 | |||||
| WOOLLEY, James Christopher Michael | Administrateur | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | England | British | 156851530001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 17 déc. 2014 Livré le 19 déc. 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 17 juil. 2013 Livré le 19 juil. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of trustmarque acquisitions limited.. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 07 juin 2013 Livré le 14 juin 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 12 août 2006 Livré le 18 août 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge of securities | Créé le 12 août 2006 Livré le 18 août 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Its whole right title and benefit of the securities and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 25 juin 2002 Livré le 09 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 05 juin 2002 Livré le 11 juin 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 05 avr. 2002 Livré le 17 avr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0