DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED

DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDORMANT COMPANY 04401640 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04401640
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRUSTMARQUE ACQUISITIONS LIMITED04 avr. 200204 avr. 2002
    BROOMCO (2860) LIMITED22 mars 200222 mars 2002

    Quels sont les derniers comptes de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    15 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 déc. 2016

    14 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT à 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place Southampton SO15 2BG le 05 déc. 2016

    2 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 044016400008 en totalité

    1 pagesMR04

    État du capital après une attribution d'actions au 14 déc. 2015

    • Capital: GBP 6,348,851
    3 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor 100 Wood Street London EC2V 7AN à Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT le 04 janv. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 déc. 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Cessation de la nomination de Martin John Trainer en tant que directeur le 14 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Charles Mills en tant que secrétaire le 14 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Dermot James Joyce en tant que directeur le 14 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed trustmarque acquisitions LIMITED\certificate issued on 11/12/15
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name11 déc. 2015

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de James Christopher Michael Woolley en tant que directeur le 03 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Neil Martin Simpson en tant que directeur le 26 mai 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 avr. 2015

    État du capital au 17 avr. 2015

    • Capital: GBP 810
    SH01

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Dermot James Joyce le 11 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Peter Charles Mills le 02 févr. 2015

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Christopher Michael Woolley le 02 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martin John Trainer le 02 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Dermot James Joyce le 02 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FERGUSON, Paul John
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    British84739280002
    GODLIMAN, Victoria
    Triune Court
    Monks Cross Drive, Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    Secrétaire
    Triune Court
    Monks Cross Drive, Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    167818480001
    METCALFE, Richard Crosby, Mr.
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    Secrétaire
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    British73646130001
    MILLS, Peter Charles
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Secrétaire
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    191202760001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BLOW, Bridget Penelope
    Flat 119 B Central
    38 Paradise Street
    B1 2AF Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    Flat 119 B Central
    38 Paradise Street
    B1 2AF Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish115125670001
    COOKE, Ursula
    70 Bootham
    YO30 7DF York
    Administrateur
    70 Bootham
    YO30 7DF York
    British115125770002
    FERGUSON, Paul John
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    Administrateur
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    EnglandBritish84739280002
    FINLAYSON, David John Mcintosh
    8 Greenfields
    New Barn Lane Prestbury
    GL52 3LG Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    8 Greenfields
    New Barn Lane Prestbury
    GL52 3LG Cheltenham
    Gloucestershire
    British33124430005
    GODLIMAN, Victoria
    Triune Court
    Monks Cross Drive, Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    Administrateur
    Triune Court
    Monks Cross Drive, Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    EnglandBritish83684440003
    HADDOW, Scott William
    Chelford Road
    WA16 8LY Knutsford
    Spinney End
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8LY Knutsford
    Spinney End
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish121651070002
    JOYCE, Dermot James
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Administrateur
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    United KingdomIrish181301350001
    LIGERTWOOD, Mark Murray
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomUk179214640001
    LLOYD, Colin Thomas
    Fawke Common
    Underriver
    TN15 0JX Sevenoaks
    Fawke House
    Kent
    Administrateur
    Fawke Common
    Underriver
    TN15 0JX Sevenoaks
    Fawke House
    Kent
    United KingdomBritish3616430001
    METCALFE, Richard Crosby, Mr.
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    Administrateur
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    United KingdomBritish73646130001
    MILLER, Ross Charles
    Primrose Farm
    Hagg Lane Dunnington
    YO19 5PE York
    Yorkshire
    Administrateur
    Primrose Farm
    Hagg Lane Dunnington
    YO19 5PE York
    Yorkshire
    EnglandBritish84739210001
    ROGERS, Christine Margaret
    The Old Granary
    Chilton Road
    HP18 0DN Chearsley
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Old Granary
    Chilton Road
    HP18 0DN Chearsley
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish66374680002
    SIMPSON, Neil Martin
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Administrateur
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    United KingdomBritish183192810001
    TRAINER, Martin John
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Administrateur
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    EnglandBritish124180840001
    WOOLLEY, James Christopher Michael
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Administrateur
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    EnglandBritish156851530001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2014
    Livré le 19 déc. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transactions
    • 19 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 juil. 2013
    Livré le 19 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of trustmarque acquisitions limited.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Senior Security Agent
    Transactions
    • 19 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 juin 2013
    Livré le 14 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dcg Nominees Limited (As Security Trustee)
    Transactions
    • 14 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 12 août 2006
    Livré le 18 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge of securities
    Créé le 12 août 2006
    Livré le 18 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Its whole right title and benefit of the securities and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 25 juin 2002
    Livré le 09 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Investments Limited
    Transactions
    • 09 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 05 juin 2002
    Livré le 11 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Investments Limited
    Transactions
    • 11 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 05 avr. 2002
    Livré le 17 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Investments Limited
    Transactions
    • 17 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 déc. 2015Commencement of winding up
    10 avr. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen John Adshead
    Smith & Williamson Llp Imperial House
    18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    practitioner
    Smith & Williamson Llp Imperial House
    18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Gregory Andrew Palfrey
    Imperial House 18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Hampshire
    practitioner
    Imperial House 18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0