FOCUSEDUCATION (NEWCASTLE) HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | FOCUSEDUCATION (NEWCASTLE) HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04402761 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FOCUSEDUCATION (NEWCASTLE) HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Albany Spc Services Ltd 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FOCUSEDUCATION (NEWCASTLE) HOLDINGS LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour FOCUSEDUCATION (NEWCASTLE) HOLDINGS LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 25 mars 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 08 avr. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 25 mars 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour FOCUSEDUCATION (NEWCASTLE) HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Nomination de Mr Barry Paul Millsom en tant qu'administrateur le 23 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Michael James Williams en tant qu'administrateur le 12 juin 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Johan Hendrik Potgieter en tant que directeur le 12 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Albany Secretariat Limited en tant que secrétaire le 22 juin 2023 | 2 pages | AP04 | ||
Cessation de la nomination de Ailison Louise Mitchell en tant que secrétaire le 22 juin 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 20 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Leo William Mckenna le 24 avr. 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 21 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 18 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Johan Hendrik Potgieter le 28 juin 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Leo William Mckenna le 04 janv. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 19 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 18 pages | AA | ||
Nomination de Mr Johan Hendrik Potgieter en tant qu'administrateur le 10 mai 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Lynn Bridget Murphy en tant que directeur le 10 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Ms Lynn Bridget Murphy en tant qu'administrateur le 04 sept. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Johan Hendrik Potgeiter en tant que directeur le 12 juil. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Kenneth William Gillespie en tant que directeur le 16 juil. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de FOCUSEDUCATION (NEWCASTLE) HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBANY SECRETARIAT LIMITED | Secrétaire | Charlotte Street M1 4HB Manchester 3-5 Charlotte Street England |
| 303585870001 | ||||||||||
DONN, Michael Andrew | Administrateur | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | Banker | 108352120001 | ||||||||
MCKENNA, Leo William | Administrateur | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Northern Ireland | Northern Irish | Director | 164592610004 | ||||||||
MILLSOM, Barry Paul | Administrateur | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | Director | 190982570023 | ||||||||
SOLLEY, Christopher Thomas | Administrateur | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | United Kingdom | British | Director | 166666620001 | ||||||||
WILLIAMS, Michael James | Administrateur | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | Director | 263619910002 | ||||||||
MITCHELL, Ailison Louise | Secrétaire | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | British | Company Secretary | 53150080001 | |||||||||
HLM SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 1st Floor 25 Stamford Street WA14 1EX Altrincham Cheshire | 118686920001 | |||||||||||
ANDERSON, Thomas Downs | Administrateur | 157 Percheron Drive The Mount GU21 2QX Knaphill Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 54976140002 | ||||||||
ASHBROOK, Philip Peter | Administrateur | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | United Kingdom | British | Project Finance Consultant | 121252960001 | ||||||||
BREE, Rhona Macdonald | Administrateur | Flat 3/2 64 Miller Street G1 1DT Glasgow Lanarkshire | British | Banker | 99563640001 | |||||||||
COHEN, Gershon Daniel | Administrateur | Trees 82 Millway NW7 3JJ London | United Kingdom | British | Financier | 77776830001 | ||||||||
COLEMAN, Martin John | Administrateur | Field House 8 The Square Leasingham NG34 8LA Sleaford Lincolnshire | United Kingdom | British | Project Manager | 112237800001 | ||||||||
DAVIS, Michael Edward | Administrateur | Alpraham Hall Barns Alpraham Green CW6 9LJ Tarporley 1 Cheshire | England | British | Director | 139286050002 | ||||||||
DAVIS, Michael Edward | Administrateur | Thaxted Road Wimbish CB10 2UT Walden Swans Essex | British | Director | 131778860001 | |||||||||
DICKIE, Timothy John | Administrateur | 51 Summerside Place EH6 4NY Edinburgh | British | Banker | 107164130002 | |||||||||
ENDLER, Steven | Administrateur | 6 Springfield Court Higher Kinnerton CH4 9BY Chester Cheshire | England | British | Bsf Bid Leader | 94321530001 | ||||||||
GILLESPIE, Kenneth William | Administrateur | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | Banker | 105139700001 | ||||||||
GILLESPIE, Kenneth William | Administrateur | 7 Shaws Crescent EH26 0RE Milton Bridge Midlothian | Scotland | British | Banker | 105139700001 | ||||||||
GRANT, Philip Robert | Administrateur | 40 Lumsdaine Drive KY11 9YU Dalgety Bay Fife | British | Director | 76673520001 | |||||||||
HOCKADAY, Stephen | Administrateur | 33a Arterberry Road SW20 8AG London | England | British | Director | 101894100001 | ||||||||
JACKSON, Gregor Scott | Administrateur | Towers Business Park Wilmslow Road M20 2YY Manchester Albany Spc Services Ltd, Adamson House England | England | British | Director | 191227420001 | ||||||||
MASON, Andrew Craig | Administrateur | 159 28 Slateford Road EH14 1PB Edinburgh | British | Banker | 89205660001 | |||||||||
MILLSOM, Barry Paul | Administrateur | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | Director | 190982570001 | ||||||||
MILLSOM, Barry Paul | Administrateur | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | British | Fund Manager | 156461120001 | ||||||||
MURPHY, Helen Mary | Administrateur | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | Irish | Accountant | 156461710001 | ||||||||
MURPHY, Lynn Bridget | Administrateur | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | United Kingdom | British | Consultant | 258209470001 | ||||||||
NEVILLE, Gary Arthur | Administrateur | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | British | Director | 156463000001 | ||||||||
OSTLE, John Daniel | Administrateur | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | United Kingdom | British | General Manager | 152482480001 | ||||||||
POTGEITER, Johan Hendrik | Administrateur | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | South African | Director | 247224630001 | ||||||||
POTGIETER, Johan Hendrik | Administrateur | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | South African | Director | 258420160002 | ||||||||
POTGIETER, Johan Hendrik | Administrateur | Towers Business Park Wilmslow Road M20 2YY Manchester Albany Spc Services Ltd, Adamson House England | England | South African | Director | 173393140001 | ||||||||
SILVERBECK, Andrew David | Administrateur | The Orchard 12 Barham Avenue WD6 3PN Elstree Hertfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 68603270002 | ||||||||
TURNBULL-FOX, Moira | Administrateur | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | British | Assistant Fund Manager | 156461580001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FOCUSEDUCATION (NEWCASTLE) HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Focuseducation Limited | 03 sept. 2016 | 3rd Floor, 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
FOCUSEDUCATION (NEWCASTLE) HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge entitled "hc debenture" | Créé le 18 avr. 2002 Livré le 30 avr. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from focuseducation (newcastle) limited or the company to any senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all the shares, rights attaching or relating to the shares, present and future investments, uncalled capital and goodwill. By way of floating charge all the undertaking, and all its assets whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0