NORTHWICH HEADLEASE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORTHWICH HEADLEASE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04410247
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORTHWICH HEADLEASE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe NORTHWICH HEADLEASE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de NORTHWICH HEADLEASE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour NORTHWICH HEADLEASE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    38 pagesLIQ13

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU à Duff & Phelps Ltd the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG le 17 juil. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 juin 2017

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 05 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Valad Secretarial Services Limited le 24 févr. 2017

    1 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Valsec Director Limited le 24 févr. 2017

    1 pagesCH02

    Nomination de Ms Ciara Fitzgibbon en tant qu'administrateur le 24 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neil Kenneth Robertson en tant que directeur le 24 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 avr. 2016

    État du capital au 08 avr. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mr Neil Kenneth Robertson en tant qu'administrateur le 05 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Claire Treacy en tant que directeur le 05 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Nomination de Mrs Claire Treacy en tant qu'administrateur le 31 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David John Kirkby en tant que directeur le 31 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 avr. 2015

    État du capital au 10 avr. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 avr. 2014

    État du capital au 11 avr. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de NORTHWICH HEADLEASE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520004
    FITZGIBBON, Ciara
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish225576850001
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5307786
    102622300003
    NAIK, Varsha
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    British101693390001
    HALCO SECRETARIES LIMITED
    8-10 New Fetter Lane
    EC4A 1RS London
    Secrétaire
    8-10 New Fetter Lane
    EC4A 1RS London
    42871950001
    BOWMAN, Gary John
    Le Pre Du Haut
    Rue De Grantez
    JE3 4DG St Owen
    Jersey
    Channel Islands
    Administrateur
    Le Pre Du Haut
    Rue De Grantez
    JE3 4DG St Owen
    Jersey
    Channel Islands
    British79684770002
    CAPPS, David John
    Shibui
    Route De La Villaise
    JE3 2AP Millais
    St Ouen
    Jersey
    Administrateur
    Shibui
    Route De La Villaise
    JE3 2AP Millais
    St Ouen
    Jersey
    British75686940005
    CARTER KEALL, Christopher Philip
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish153912870001
    COOMBS-GOODFELLOW, Ian Christopher
    Sandhurst Causie Drive
    St Clement
    JE2 6SR Jersey
    Channel Islands
    Administrateur
    Sandhurst Causie Drive
    St Clement
    JE2 6SR Jersey
    Channel Islands
    British79683160001
    CORLETT, Robert John
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish72399980002
    KIRKBY, David John
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomAustralian110761830001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    OLIVER, Paul Francis
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    Administrateur
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    United KingdomBritish14735150002
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Administrateur
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    THOMAS, Andrew James
    Longueville Road, St Saviour
    JE2 7WF Jersey
    Channel Islands
    Administrateur
    Longueville Road, St Saviour
    JE2 7WF Jersey
    Channel Islands
    British79683170001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish189529610001
    TUTTON, Jeremy John
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    Administrateur
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    British100816670001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NORTHWICH HEADLEASE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Equity Partnerships (Osprey) Limited
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    06 avr. 2016
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement4299729
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    NORTHWICH HEADLEASE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 10 févr. 2003
    Livré le 13 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the south side of king edward street macclesfield t/n CH393674, l/h land on the north east queen street (k/a regent house) barnstaple and l/h land being part of multi-storey car park queen street barnstaple t/n DN276066 and DN311311 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 oct. 2002
    Livré le 12 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent the "Security Trustee"
    Transactions
    • 12 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 10 oct. 2002
    Livré le 12 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the osprey limited partnership acting by its general partner equity partnerships (osprey) limited to the lenders or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 24 witton street northwich t/n CH153669 and all that l/h property k/a land on the east and west of witton walk northwich t/n CH357086. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Agent)
    Transactions
    • 12 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    NORTHWICH HEADLEASE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 juin 2017Commencement of winding up
    15 avr. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0