COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED

COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04414667
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SYDNEY & BIRMINGHAM 2 LIMITED11 avr. 200211 avr. 2002

    Quels sont les derniers comptes de COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    43 pages4.71

    Cessation de la nomination de Neil Kenneth Robertson en tant que directeur le 24 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU à The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG le 11 avr. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 22 mars 2016

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    3 pagesAA

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    2 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Claire Treacy en tant que directeur le 05 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Neil Kenneth Robertson en tant qu'administrateur le 05 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Claire Treacy en tant qu'administrateur le 14 août 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Fraser James Kennedy en tant que directeur le 14 août 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 avr. 2015

    État du capital au 17 avr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 avr. 2014

    État du capital au 16 avr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Valsec Director Limited le 01 juil. 2013

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Fraser James Kennedy le 01 juil. 2013

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ* le 02 juil. 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Secrétaire
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5307786
    102622300002
    CURTIS, Wendy June
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    Secrétaire
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    British46982690003
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    CHALFEN SECRETARIES LIMITED
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    Secrétaire désigné
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    900013320001
    ANNING, Richard John
    Witchwood
    Westra
    CF64 4HA Dinas Powys
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    Witchwood
    Westra
    CF64 4HA Dinas Powys
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritish14073020003
    CHILDS, Simon John
    18 Hardwicke Court
    Llandaff
    CF5 2LB Cardiff
    Administrateur
    18 Hardwicke Court
    Llandaff
    CF5 2LB Cardiff
    WalesBritish78425720001
    CURTIS, Wendy June
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    Administrateur
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    British46982690003
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish135717740001
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Administrateur
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Administrateur
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish189529610001
    CHALFEN NOMINEES LIMITED
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    Administrateur désigné
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    900013310001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 mars 2012
    Livré le 30 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land to the north east of old park road wednesbury t/no WM398013 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 30 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession and charge
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 11 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 11 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 nov. 2002
    Livré le 22 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 08 nov. 2002
    Livré le 22 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h and l/h property k/a all saints business park all saints road wednesbury west midlands WS10 9TS t/nos WM398013 and WM695818. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed (supplemental to a deed dated 18 august 1998)
    Créé le 16 avr. 2002
    Livré le 27 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the charged properties together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 27 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over shares
    Créé le 16 avr. 2002
    Livré le 27 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 27 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 16 avr. 2002
    Acquis le 16 avr. 2002
    Livré le 24 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a all saints road wednesbury t/n WM695818 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 24 avr. 2002Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 31 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 mars 2016Commencement of winding up
    30 juil. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0