ASHTENNE (SEVERNSIDE) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ASHTENNE (SEVERNSIDE) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04415134 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ASHTENNE (SEVERNSIDE) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 3 Copthall Avenue EC2R 7BH London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ASHTENNE (SEVERNSIDE) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ASHTENNE (SEVERNSIDE) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 avr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 25 avr. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 avr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour ASHTENNE (SEVERNSIDE) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 9 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 avr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 044151340005 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 044151340006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 044151340008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 044151340007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 044151340009 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 044151340010 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 044151340012 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 044151340011 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 2 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Simon Jeffrey Payne en tant que secrétaire le 12 mai 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Inscription de la charge 044151340013, créée le 13 févr. 2024 | 245 pages | MR01 | ||
Modification des détails de Ashtenne Industrial (General Partner) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 sept. 2023 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de 12 st. James's Square London SW1Y 4LB England à 3 Copthall Avenue London EC2R 7BH le 14 sept. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 2 pages | AA | ||
Nomination de Mr Christopher Alan Watkins en tant qu'administrateur le 16 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Philip Mathew Cridge en tant que directeur le 16 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Simon Jeffrey Payne en tant que secrétaire le 01 janv. 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Intertrust (Uk) Limited en tant que secrétaire le 01 janv. 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Changement d'adresse du siège social de 1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX England à 12 st. James's Square London SW1Y 4LB le 05 janv. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Mathew Cridge le 09 juil. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Daniel George Roberts le 19 mai 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Qui sont les dirigeants de ASHTENNE (SEVERNSIDE) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Andrew Richard | Administrateur | Copthall Avenue EC2R 7BH London 3 England | England | British | 283776100001 | |||||||||
| ROBERTS, Daniel George | Administrateur | Copthall Avenue EC2R 7BH London 3 England | England | British | 267246940002 | |||||||||
| SPEARING, Glen Stuart | Administrateur | Copthall Avenue EC2R 7BH London 3 England | Scotland | British | 284967170001 | |||||||||
| WATKINS, Christopher Alan | Administrateur | Copthall Avenue EC2R 7BH London 3 England | United Kingdom | British | 304773820001 | |||||||||
| FURMSTON, Teresa | Secrétaire | Pegasus House 37-43 Sackville Street, W1s 3dl London 1st Floor United Kingdom | 210674170001 | |||||||||||
| LANCHESTER, David James | Secrétaire | 1 Holly Close IG9 6HT Buckhurst Hill Essex | British | 7014460002 | ||||||||||
| LOWES, Richard Phillip | Secrétaire | 2 Westcott Keep RH6 9US Horley Surrey | British | 5785520001 | ||||||||||
| NELSON SMITH, Richard John | Secrétaire | Stable Cottage Chew Court Farm Chew Magna BS40 8SF Bristol Avon | British | 64685100003 | ||||||||||
| PAYNE, Simon Jeffrey | Secrétaire | St. James's Square SW1Y 4LB London 12 England | 303873370001 | |||||||||||
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's England |
| 1278390004 | ||||||||||
| INTERTRUST (UK) LIMITED | Secrétaire | Bartholomew Lane EC2N 2AX London 1 England |
| 188126550001 | ||||||||||
| LINK COMPANY MATTERS LIMITED | Secrétaire | 34 Beckenham Road Beckenham BR3 4TU Kent The Registry England England |
| 102944500002 | ||||||||||
| OVALSEC LIMITED | Secrétaire | 30 Queen Charlotte Street BS99 7QQ Bristol | 56728540001 | |||||||||||
| COLLINS, Peter William | Administrateur | The Oaks 23 Croft Road RG40 3HX Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 26086560001 | |||||||||
| CRIDGE, Philip Mathew | Administrateur | St. James's Square SW1Y 4LB London 12 England | United Kingdom | British | 267173330002 | |||||||||
| GAME, Robert William | Administrateur | Newbury Lane Cousley Wood TN5 6HD Wadhurst Rosemary Cottage East Sussex | United Kingdom | English | 139555050001 | |||||||||
| HAVERY, James Mark | Administrateur | Floor Clarendon House 12 Clifford Street W1S 2LL London 6th England England | England | British | 203008080001 | |||||||||
| HEATHWOOD, Derek Kevin | Administrateur | Clarendon House 12 Clifford Street W1S 2LL London 6th Floor England England | Scotland | British | 85468580005 | |||||||||
| HEAWOOD, John Anthony Nicholas | Administrateur | South View Road HA5 3YB Pinner Gateway Middlesex | United Kingdom | British | 133123780001 | |||||||||
| HOWLETT, Benjamin | Administrateur | Bartholomew Lane EC2N 2AX London 1 England | England | British | 266872710001 | |||||||||
| JONES, Morgan Lewis | Administrateur | Pegasus House 37-43 Sackville Street W1S 3EH London 1st Floor | United Kingdom | British | 10146340004 | |||||||||
| JONES, Morgan Lewis | Administrateur | 4 Camden Close BR7 5PH Chislehurst Kent | England | British | 10146340003 | |||||||||
| KEOGH, Mark William | Administrateur | Norfolk House 28 Kidmore Road Caversham RG4 7LU Reading | England | Irish | 62140690001 | |||||||||
| LINDSAY, Sarah Jane | Administrateur | Pegasus House 37-32 Sackville Street W1S 3DL London First Floor England And Wales United Kingdom | England | British | 274330770001 | |||||||||
| LOWES, Richard Phillip | Administrateur | Floor Clarendon House 12 Clifford Street W1S 2LL London 6th England England | England | British | 5785520001 | |||||||||
| MATHER, William Gordon | Administrateur | 36 St Johns Road Clifton BS8 2HG Bristol | United Kingdom | British | 7334070001 | |||||||||
| MCDONALD, Janine Anne | Administrateur | Bartholomew Lane EC2N 2AX London 1 England | England | British | 90973170001 | |||||||||
| MEADE, Karl Robert | Administrateur | Holly Mount Penn Road HP9 2TS Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 118074370001 | |||||||||
| MOORE, Richard | Administrateur | 88 Alzey Gardens AL5 5SZ Harpenden Hertfordshire | British | 73793650001 | ||||||||||
| OVENS, Mark Douglas | Administrateur | Poultry EC2R 8EJ London No.1 England | United Kingdom | British | 56734030003 | |||||||||
| OVENS, Mark Douglas | Administrateur | Birdhurst 37 The Warren SM5 4EQ Carshalton Surrey | United Kingdom | British | 56734030003 | |||||||||
| STEVENS, Michael John | Administrateur | 32 Woodfield Park HP6 5QH Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 60348780002 | |||||||||
| VAGHELA, Vinod Bachulal | Administrateur | 99 Cathles Road Balham SW12 9LF London | England | British | 5689250001 | |||||||||
| WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir | Administrateur | Marden Grange Marden SN10 3RQ Devizes Wiltshire | United Kingdom | British | 7356840002 | |||||||||
| WATSON, Ian Richard | Administrateur | Floor Clarendon House 12 Clifford Street W1S 2LL London 6th England England | England | British | 68256540001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASHTENNE (SEVERNSIDE) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Allen Schwarzman | 27 févr. 2020 | 345 Park Avenue NY 10154 New York C/O The Blackstone Group Inc United States | Oui | ||||||||||
Nationalité: American Pays de résidence: United States | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ashtenne Industrial (General Partner) Limited | 06 avr. 2016 | Copthall Avenue EC2R 7BH London 3 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0