WASTE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED

WASTE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWASTE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04418836
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WASTE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe WASTE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1000 Lakeside North Harbour
    PO6 3EN Portsmouth
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WASTE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WASTE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au17 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation01 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au17 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour WASTE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Joanne Marie Helson en tant que directeur le 31 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2024 avec mises à jour

    19 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    29 pagesAA

    Statuts

    26 pagesMA

    Statuts

    26 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    29 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 12 mai 2023

    • Capital: GBP 5,242,807.81
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2023 avec mises à jour

    19 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Timothy Keats Urling Clark le 07 déc. 2022

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Timothy Keats Urling Clark le 07 déc. 2022

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2022 avec mises à jour

    18 pagesCS01

    Deuxième dépôt d'un bilan du capital suite à une émission d'actions au 18 oct. 2021

    • Capital: GBP 5,242,436.98
    4 pagesRP04SH01

    État du capital après une attribution d'actions au 18 oct. 2021

    • Capital: GBP 11,360,041.98
    9 pagesSH01
    Annotations
    DateAnnotation
    20 avr. 2022Clarification A second filed SH01 was registered on 20/04/2022.

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen John Noar le 26 juil. 2021

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2021 avec mises à jour

    16 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    28 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    28 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2020 avec mises à jour

    16 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    30 pagesAA

    Nomination de Timothy Keats Urling Clark en tant que secrétaire le 05 juil. 2019

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard James Scarrott en tant que secrétaire le 05 juil. 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Richard James Scarrott en tant que directeur le 05 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Timothy Keats Urling Clark en tant qu'administrateur le 05 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de WASTE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLARK, Timothy Keats Urling
    Goose Green Lane
    West Harting
    GU31 5PD Petersfield
    Goosegreen Cottage
    West Sussex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Goose Green Lane
    West Harting
    GU31 5PD Petersfield
    Goosegreen Cottage
    West Sussex
    United Kingdom
    260291790001
    CLARK, Timothy Keats Urling
    Goose Green Lane
    West Harting
    GU31 5PD Petersfield
    Goosegreen Cottage
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Goose Green Lane
    West Harting
    GU31 5PD Petersfield
    Goosegreen Cottage
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector260254500002
    JONES, David Gareth Lloyd
    18 Saxon Road
    SO23 7DJ Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    18 Saxon Road
    SO23 7DJ Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritishAdvertising83911010001
    LAST, Richard
    Ledwell
    OX7 4DL Oxfordshire
    Hobbs Hole Farm
    United Kingdom
    Administrateur
    Ledwell
    OX7 4DL Oxfordshire
    Hobbs Hole Farm
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector80537570001
    MCGUINNESS, Alan
    BN3 5FT Hove
    64 Marmion Road
    East Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    BN3 5FT Hove
    64 Marmion Road
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector151465280002
    NOAR, Stephen John
    North Harbour
    PO6 3EN Portsmouth
    1000 Lakeside
    United Kingdom
    Administrateur
    North Harbour
    PO6 3EN Portsmouth
    1000 Lakeside
    United Kingdom
    BahamasBritishDirector64053050013
    BENNETT, James Ogilvy John
    Kingswood Farm
    Kingswood
    TA4 3TP Taunton
    Somerset
    Secrétaire
    Kingswood Farm
    Kingswood
    TA4 3TP Taunton
    Somerset
    British96074860002
    BENNETT, James Ogilvy John
    Hagleys House
    Crowcombe
    TA4 4AF Taunton
    Somerset
    Secrétaire
    Hagleys House
    Crowcombe
    TA4 4AF Taunton
    Somerset
    British96074860001
    COE, Robin Francis
    Woodlands 42 Beatrice Avenue
    IP11 9HB Felixstowe
    Suffolk
    Secrétaire
    Woodlands 42 Beatrice Avenue
    IP11 9HB Felixstowe
    Suffolk
    British91151050001
    SCARROTT, Richard James
    Surrenden Road
    BN1 6PQ Brighton
    57
    East Sussex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Surrenden Road
    BN1 6PQ Brighton
    57
    East Sussex
    United Kingdom
    BritishFinance Director94328180001
    MARTIN AND COMPANY (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    25 St Thomas Street
    SO23 9HJ Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    25 St Thomas Street
    SO23 9HJ Winchester
    Hampshire
    83188590001
    TURNERS NOMINEES
    8 Church Street
    BH21 1PN Wimborne
    Dorset
    Secrétaire
    8 Church Street
    BH21 1PN Wimborne
    Dorset
    49517350001
    BARBER, Lisa Estelle
    Owens Road
    Fulflood
    SO22 6RU Winchester
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Owens Road
    Fulflood
    SO22 6RU Winchester
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Marketing140013690003
    BENNETT, James Ogilvy John
    Kingswood Farm
    Kingswood
    TA4 3TP Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Kingswood Farm
    Kingswood
    TA4 3TP Taunton
    Somerset
    United KingdomBritishDirector96074860002
    BEWES, Nicholas Cecil John
    Beechwood
    Newton Road, Little Shelford
    CB22 5HL Cambridge
    Administrateur
    Beechwood
    Newton Road, Little Shelford
    CB22 5HL Cambridge
    EnglandBritishDirector64093580002
    HELSON, Joanne Marie
    Burleston
    DT2 7EG Dorchester
    The Old Rectory
    Dorset
    United Kingdom
    Administrateur
    Burleston
    DT2 7EG Dorchester
    The Old Rectory
    Dorset
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector80602900003
    JUDD, James Grant
    The Malt House
    High Street
    SO32 3NH Meonstoke
    Hampshire
    Administrateur
    The Malt House
    High Street
    SO32 3NH Meonstoke
    Hampshire
    BritishBuilding Contractor83910960001
    SCARROTT, Richard James
    Surrenden Road
    BN1 6PQ Brighton
    57
    East Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Surrenden Road
    BN1 6PQ Brighton
    57
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director94328180002
    WALLNER, Edgar
    Bray Road
    SL6 1UQ Maidenhead
    Somerville
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Bray Road
    SL6 1UQ Maidenhead
    Somerville
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishRetired President27935680002
    WATES, James Garwood Michael
    Melrose
    Logmore Lane, Westcott
    RH4 3JY Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Melrose
    Logmore Lane, Westcott
    RH4 3JY Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishBuilder/Developer43991900001
    TURNECTOR LIMITED
    8 Church Street
    BH21 1PN Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    8 Church Street
    BH21 1PN Wimborne
    Dorset
    51884330001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour WASTE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    17 avr. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    WASTE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 nov. 2012
    Livré le 07 déc. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aldermore Invoice Finance, a Division of Aldermore Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 sept. 2011
    Livré le 30 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Quentin Skinner and Philip Mason
    Transactions
    • 30 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 01 sept. 2011
    Livré le 06 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Edgar Wallner
    Transactions
    • 06 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 01 sept. 2011
    Livré le 06 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Richard Last
    Transactions
    • 06 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 01 sept. 2011
    Livré le 06 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Stephen Noar
    Transactions
    • 06 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of deposit
    Créé le 06 mai 2009
    Livré le 09 mai 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The monies comprised in the deposit account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Phoenix Properties Limited
    Transactions
    • 09 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 2008
    Livré le 24 déc. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Quentin Skinner and Philip Mason in Their Capacity as Security Trustees for the Security Beneficiaries
    Transactions
    • 24 déc. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0