MORTGAGE AGENCY SERVICES NUMBER FIVE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MORTGAGE AGENCY SERVICES NUMBER FIVE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04420522 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MORTGAGE AGENCY SERVICES NUMBER FIVE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 Balloon Street M4 4BE Manchester United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MORTGAGE AGENCY SERVICES NUMBER FIVE LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MORTGAGE AGENCY SERVICES NUMBER FIVE LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 févr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 20 févr. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 févr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MORTGAGE AGENCY SERVICES NUMBER FIVE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 23 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Lee John Raybould en tant qu'administrateur le 01 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Louise Britnell en tant que directeur le 31 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 févr. 2025 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Catherine Elizabeth Green le 22 août 2024 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Louise Britnell le 22 août 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Michael Hiom le 22 août 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des détails de The Co-Operative Bank Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 juin 2024 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , PO Box 101 1 Balloon Street, Manchester, M60 4EP, United Kingdom à 1 Balloon Street Manchester M4 4BE le 07 juin 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 28 pages | AA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 22 mars 2024
| 5 pages | SH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Catherine Elizabeth Green le 08 mars 2024 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 29 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 févr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Richard Michael Hiom en tant qu'administrateur le 22 juil. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Stuart Slape en tant que directeur le 22 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 30 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 févr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Louise Britnell le 09 juin 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 27 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 févr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Stuart Slape le 26 janv. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 26 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de MORTGAGE AGENCY SERVICES NUMBER FIVE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN, Catherine Elizabeth | Secrétaire | Balloon Street M4 4BE Manchester 1 United Kingdom | 255933670001 | |||||||
| HIOM, Richard Michael | Administrateur | Balloon Street M4 4BE Manchester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 292500730001 | |||||
| RAYBOULD, Lee John | Administrateur | c/o Secretariat, 6th Floor Balloon Street M4 4BE Manchester 1 England | England | British | 276168520001 | |||||
| ARNOLD, Katy Jane | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | 192245780001 | |||||||
| GREEN, Robin Sinclair | Secrétaire | 9 Buckland Grove New Park ST4 8UG Trentham Staffordshire | British | 5782770001 | ||||||
| MCKEOWN, Brona Rose | Secrétaire | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | 193735750001 | |||||||
| MEDFORD, Paul Derek | Secrétaire | 25 Bromley Drive CW4 7AX Holmes Chapel Cheshire | British | 123495670001 | ||||||
| MILLS, Paul Andrew | Secrétaire | Woodcote 8 Hall Orchard Bramshall ST14 5DF Uttoxeter Staffordshire | British | 34173070002 | ||||||
| MOSS, Susan | Secrétaire | 9th Floor 1 Angel Square M60 0AG Manchester Corporate Governance United Kingdom | 153215690001 | |||||||
| WADE, Patricia Anne | Secrétaire | Corporation Street M60 4ES Manchester New Century House United Kingdom | 147830810001 | |||||||
| WHITEHEAD, David Clive | Secrétaire | Balloon Street M60 4EP Manchester C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1 United Kingdom | 196682580001 | |||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| AITKEN, Stephen | Administrateur | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British,Australian | 188712540001 | |||||
| ALDERSON, Keith Brian | Administrateur | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | England | British | 101986420001 | |||||
| ALDERSON, Keith Brian | Administrateur | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | England | British | 101986420001 | |||||
| ALTHAM, Richard David | Administrateur | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | United Kingdom | British | 146408190001 | |||||
| BRITNELL, Louise Jeanette | Administrateur | Balloon Street M4 4BE Manchester 1 United Kingdom | England | British | 234471640001 | |||||
| GARLICK, Philip Michael | Administrateur | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | United Kingdom | British | 151356580001 | |||||
| GOSLING, Clare Louise | Administrateur | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British | 204863170001 | |||||
| GREEN, Robin Sinclair | Administrateur | 9 Buckland Grove New Park ST4 8UG Trentham Staffordshire | British | 5782770001 | ||||||
| GREGORY, Gerald Arthur | Administrateur | Gatepiece House Quarry Bank DE4 3LF Matlock Derbyshire | England | British | 31843730001 | |||||
| HUGHES, John Richard | Administrateur | 9th Floor 1 Angel Square M60 0AG Manchester Corporate Governance United Kingdom | England | British | 146426540002 | |||||
| KATOVSKY, Jon Ian | Administrateur | 2 Grange Road SK7 3BD Bramhall Cheshire | United Kingdom | American | 147983920001 | |||||
| LAYTON, Matthew Robert | Administrateur désigné | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| LEE, Phillip Andrew | Administrateur | 11 Badger Road SK10 4JG Prestbury Cheshire | United Kingdom | British | 89215420001 | |||||
| LEWIS, Michael George | Administrateur | 10 Nightingale Close Elburton PL9 8PN Plymouth Devon | England | British | 63553970003 | |||||
| LILLIE, Ashley John William | Administrateur | Balloon Street M60 4EP Manchester C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 196579370001 | |||||
| MCCARTHY, David James | Administrateur | Far End Sheepscombe GL6 7RL Stroud Knapp House Gloucestershire | England | British | 91557750002 | |||||
| MILLER, David Michael | Administrateur | Balloon Street M60 4EP Manchester C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1 United Kingdom | England | British | 201054530001 | |||||
| MILLS, Paul Andrew | Administrateur | Woodcote 8 Hall Orchard Bramshall ST14 5DF Uttoxeter Staffordshire | England | British | 34173070002 | |||||
| MUNDY, Daniel | Administrateur | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British | 189420920001 | |||||
| NEWBY, William Edward | Administrateur | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | United Kingdom | British | 140446620001 | |||||
| REIZENSTEIN, Anthony Jonathan | Administrateur | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | England | British | 100467920001 | |||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Administrateur désigné | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| RICHARDSON, Caroline Jane | Administrateur | Balloon Street M60 4EP Manchester C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 230186390002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MORTGAGE AGENCY SERVICES NUMBER FIVE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Co-Operative Bank Plc | 29 mars 2017 | Balloon Street M4 4BE Manchester 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Britannia Treasury Services Limited | 06 avr. 2016 | Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester Secretariat England England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0