WYNDEHAM BLACKETTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | WYNDEHAM BLACKETTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04420587 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WYNDEHAM BLACKETTS LIMITED ?
Adresse du siège social | 18 Westside Centre London Road Stanway CO3 8PH Colchester England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WYNDEHAM BLACKETTS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour WYNDEHAM BLACKETTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Walstead Uk Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 janv. 2022 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH England à 18 Westside Centre London Road Stanway Colchester CO3 8PH le 16 déc. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019 | 3 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH England à 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH le 02 oct. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Zoe Repman en tant que secrétaire le 19 sept. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018 | 2 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 avr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2016 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Bentalls Complex Colchester Road Heybridge Essex CM9 4NW à 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH le 24 août 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul George Utting le 22 juin 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de WYNDEHAM BLACKETTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTING, Paul George | Administrateur | Westside Centre, London Road CO3 8PH Colchester 22 Essex England | England | British | Director | 65550960005 | ||||
ALEXANDER, Barbara Ann | Secrétaire | 47 Mill Place BR7 5ND Chislehurst Kent | British | Director | 82262300001 | |||||
GEORGIOU, George | Secrétaire | 54 Old Street EC1V 9AJ London | British | 110805430001 | ||||||
HOLLEBONE, Paul Stephen | Secrétaire | Old Orchard Dog Lane BN44 3GE Steyning West Sussex | British | Chartered Accountant | 15201600002 | |||||
REPMAN, Zoe | Secrétaire | Westside Centre London Road CO3 8PH Colchester 22 Essex England | 147886140001 | |||||||
SLATER, Edward | Secrétaire | 4 Abbey Close Elmbridge Gate CM5 0TR Fyfield Essex | British | Accountant | 3190430005 | |||||
UTTING, Paul George | Secrétaire | 2 Walpole Gardens Strawberry Hill TW2 5SJ Twickenham | British | 65550960004 | ||||||
PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED | Secrétaire désigné | 229 Nether Street N3 1NT London | 900001530001 | |||||||
ALEXANDER, Barbara Ann | Administrateur | 47 Mill Place BR7 5ND Chislehurst Kent | British | Director | 82262300001 | |||||
ALLEN, Martyn Jeffrey | Administrateur | Hazelwood 27b Willowside RG5 4HJ Woodley Berkshire | England | British | Consultant | 167602970001 | ||||
BLYTH, Michael David | Administrateur | 256 Springfield Road CM2 6AR Chelmsford Essex | British | Printer | 74868550001 | |||||
BRANT, Neil | Administrateur | 17 Ashbourne Avenue South Woodford E18 1PJ London | England | British | Group Production Director | 91324660001 | ||||
CARTIN, Michael | Administrateur | 42 Penningtons CM23 4LF Bishops Stortford Hertfordshire | British | Printer | 96059170001 | |||||
COOCH, June | Administrateur | 1 Misbourne House Amersham Road HP8 4RY Chalfont St Giles | British | Secretary | 82011550001 | |||||
COPPOCK, Lawrence Patrick | Administrateur | The Close Church Lane SO51 0QH Braishfield Hampshire | England | United Kingdom | Chartered Accountant | 152718990001 | ||||
DAVIDSON, Stuart | Administrateur | 19 Elizabeth Way Brightlingsea CO7 0LR Colchester Essex | British | Production Director | 104480320001 | |||||
FEGAN, Felix | Administrateur | 1 Misbourne House Amersham Road HP8 4RY Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | Property Developer | 84723690001 | |||||
HOLLEBONE, Paul Stephen | Administrateur | Old Orchard Dog Lane BN44 3GE Steyning West Sussex | England | British | Chartered Accountant | 15201600002 | ||||
JONES, Robin | Administrateur | Walnut Tree Cottage 40 Drury Lane CB7 5XY Wicken Cambridgeshire | United Kingdom | British | Marketing Exec | 125146240001 | ||||
MILLS, Stephen Daniel | Administrateur | Hazlenut Cottage Whiteley Lane Burridge SO31 1BR Southampton Hampshire | Great Britain | British | Print Consultant | 58662150001 | ||||
OWEN, Jonathan Spencer | Administrateur | 42 Woodland Avenue BN3 6BL Hove East Sussex | British | Chartered Accountant | 92040070002 | |||||
PAGE, Andrew Stephen | Administrateur | 29 Russell Avenue MK40 3TD Bedford Bedfordshire | England | British | Director | 86557080001 | ||||
SLATER, Edward | Administrateur | 4 Abbey Close Elmbridge Gate CM5 0TR Fyfield Essex | British | Accountant | 3190430005 | |||||
PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED | Administrateur désigné | 229 Nether Street N3 1NT London | 900001520001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WYNDEHAM BLACKETTS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walstead United Kingdom Limited | 05 sept. 2016 | London Road Stanway CO3 8PH Colchester 18 Westside Centre England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
WYNDEHAM BLACKETTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Full form debenture | Créé le 05 déc. 2008 Livré le 19 déc. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 01 déc. 2006 Livré le 08 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattels mortgage | Créé le 01 déc. 2006 Livré le 08 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Assigns by way of security the mortgaged chattels,the benefit of any obligations,guarantees and warranties undertaken or given,all maintenance or support agreements,all authorisations,the benefit of the insurance proceeds. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of accession and restatement | Créé le 07 juin 2006 Livré le 13 juin 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Property being, the bentalls complex, colchester road, maldon, essex t/no EX443872. Castle press, 371, victoria street,grimsby t/no HS165423. Unit 11/12 grange industrial estate, grange road, southwick, west sussex t/no WSX142782. For details of further property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 03 déc. 2002 Livré le 13 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0