CAMERA MEZZ LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAMERA MEZZ LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04421871
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAMERA MEZZ LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CAMERA MEZZ LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAMERA MEZZ LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JESSOPS LIMITED10 déc. 200310 déc. 2003
    CAMERA MEZZ LIMITED21 août 200221 août 2002
    INTERCEDE 1783 LIMITED22 avr. 200222 avr. 2002

    Quels sont les derniers comptes de CAMERA MEZZ LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CAMERA MEZZ LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CAMERA MEZZ LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2012 au 31 mars 2013

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juin 2012

    État du capital au 01 juin 2012

    • Capital: GBP 70,437
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * Jessop House 98 Scudamore Road Leicester Leicestershire LE3 1TZ United Kingdom* le 24 avr. 2012

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * Jessop House Scudmore Road Leicester LE3 1TZ* le 24 avr. 2012

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Nicholas Molyneux en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Chris Yates en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Hannan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Sean Emmett en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Joanna Boydell en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Cessation de la nomination de David Cashman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Andrew Hannan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de William Rollason en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Cashman en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Période comptable actuelle prolongée du 30 nov. 2009 au 31 déc. 2009

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de CAMERA MEZZ LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BOYDELL, Joanna
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164373820001
    EMMETT, Sean Robert
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152701300001
    YATES, Chris Paul
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish152699330001
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Secrétaire
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    British48224770001
    MOLYNEUX, Nicholas John
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    British93529300001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire désigné
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    CASHMAN, David
    Jessop House
    Scudmore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Administrateur
    Jessop House
    Scudmore Road
    LE3 1TZ Leicester
    EnglandBritish152688720001
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish48224770001
    GIDDINGS, Michael John
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    British105128310002
    HANNAN, Andrew
    Jessop House
    Scudmore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Administrateur
    Jessop House
    Scudmore Road
    LE3 1TZ Leicester
    EnglandBritish153976980001
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Administrateur
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish116885790001
    HINE, Derek Leslie
    Red Lion Witley Road
    Holt Heath
    WR6 6LX Worcester
    Administrateur
    Red Lion Witley Road
    Holt Heath
    WR6 6LX Worcester
    United KingdomBritish61935280001
    REDPATH, James
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    Administrateur
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    EnglandBritish123915050001
    ROLLASON, William Peter
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Administrateur
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    United KingdomBritish67354680003
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Administrateur désigné
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900024450001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Administrateur
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001

    CAMERA MEZZ LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite debenture
    Créé le 29 sept. 2009
    Livré le 06 oct. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 sept. 2009
    Livré le 02 oct. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite debenture
    Créé le 30 août 2007
    Livré le 17 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land investments equipment book debts credit balanaces intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations in surances and other assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A supplemental deed
    Créé le 07 juin 2007
    Livré le 13 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 11 avr. 2007
    Livré le 19 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 13 sept. 2002
    Livré le 01 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 01 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CAMERA MEZZ LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 juin 2014Dissolved on
    01 juil. 2013Commencement of winding up
    05 mars 2014Conclusion of winding up
    15 mai 2013Petition date
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Leicester
    4th Floor
    Wellington House
    LE1 6HL Wellington Street
    Leicester
    practitioner
    4th Floor
    Wellington House
    LE1 6HL Wellington Street
    Leicester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0