CHESTER MEADOW LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHESTER MEADOW LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04423760
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHESTER MEADOW LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe CHESTER MEADOW LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Grant Thornton Uk Llp
    Royal Liver Building
    L3 1PS Liverpool
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CHESTER MEADOW LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CHESTER MEADOW LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CHESTER MEADOW LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    12 pages4.72

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:order of court appointing david m riley as liquidator of the company
    6 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Changement d'adresse du siège social de * Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN England* le 18 déc. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2011 au 30 juin 2012

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 avr. 2012

    État du capital au 24 avr. 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    22 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Bridge House Queens Park Road Hanbridge Chester CH88 3AN* le 27 août 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Anthony John Baker le 05 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Paul Gittins le 05 juil. 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Paul Gittins le 10 mai 2010

    1 pagesCH03

    Nomination de Esplanade Director Limited en tant qu'administrateur

    3 pagesAP02

    Cessation de la nomination de Simon Mccabe en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    7 pagesMG01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Mccabe le 09 mars 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de CHESTER MEADOW LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary45660860003
    BAKER, Anthony John
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector98969700001
    HARRIS, Richard
    21 Norton Road
    Roundhay
    LS8 2DD Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    21 Norton Road
    Roundhay
    LS8 2DD Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director118380170001
    MARTIN, Daniel James
    The Old Smithy Cottage
    Kirkby Lane
    LS22 4BR Kearby
    Leeds
    Administrateur
    The Old Smithy Cottage
    Kirkby Lane
    LS22 4BR Kearby
    Leeds
    EnglandBritishDirector83508670001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06133267
    123430390001
    DWF SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Quayside Close
    Worsley
    M28 1YB Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    3 Quayside Close
    Worsley
    M28 1YB Manchester
    Lancashire
    98269140001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BURNLEY, John Lewis
    Bloomsbury Square
    WC1A 2RN London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Bloomsbury Square
    WC1A 2RN London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritishQuantity Surveyor35543830001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Administrateur
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritishQuantity Surveyor35543830001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Administrateur
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritishQuantity Surveyor35543830001
    CHRISTIE, Alan Rodger
    6 West Lodge Drive
    CH48 5JZ West Kirby
    Administrateur
    6 West Lodge Drive
    CH48 5JZ West Kirby
    BritishDirector49798790002
    COSTELLO, Thomas
    Claddagh Shay Lane
    Oscroft
    CH3 8NW Tarvin
    Chester
    Administrateur
    Claddagh Shay Lane
    Oscroft
    CH3 8NW Tarvin
    Chester
    BritishSenior Director961140001
    FOSTER, David Paul
    Rectory Cottage
    LL16 4HN Llandrynog
    Denbighshire
    Administrateur
    Rectory Cottage
    LL16 4HN Llandrynog
    Denbighshire
    BritishSales & Development Manager60891810004
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishChartered Surveyor109250000001
    MCCABE, Simon Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishDevelopment Executive154915110001
    REYNOLDS, William Michael Hamer
    Upalond House
    Shepherds Hill
    RH1 3AD Merstham
    Surrey
    Administrateur
    Upalond House
    Shepherds Hill
    RH1 3AD Merstham
    Surrey
    BritishDirector43077730002
    RIGBY, Alan
    8 Lawn Drive
    Upton By Chester
    CH2 1ER Chester
    Cheshire
    Administrateur
    8 Lawn Drive
    Upton By Chester
    CH2 1ER Chester
    Cheshire
    BritishFinance Company Underwriter98955890001
    ROCKETT, Jason
    142 Whirlowdale Road
    Millhouses
    S7 2NL Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    142 Whirlowdale Road
    Millhouses
    S7 2NL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDevelopment Surveyor111427410002
    SMITH, Paula Jane
    44 Shaftesbury Road
    Cheadle Heath
    SK3 0SH Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    44 Shaftesbury Road
    Cheadle Heath
    SK3 0SH Stockport
    Cheshire
    BritishSolicitor79081390001

    CHESTER MEADOW LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge over account
    Créé le 01 avr. 2010
    Livré le 03 avr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee the facility agent or the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Entire right, title and interest in and to the deposit all rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit and the account; account being the account sort code 12-01-03, account number 06072643 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 03 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage
    Créé le 17 janv. 2003
    Livré le 25 janv. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at plot 4, the astolat site, old portsmouth road, peasmarsh, guildford part of t/n's SY675913, SY298516 and SY572797. By way of floating charge all unattached plant machinery and chattels belonging to the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself, the Facilityagent and the Lenders
    Transactions
    • 25 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 20 déc. 2002
    Livré le 07 janv. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee and Agent for Itself, Thefacility Agent and the Lenders)
    Transactions
    • 07 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over shares
    Créé le 20 déc. 2002
    Livré le 07 janv. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The charged shares and the proceeds of sale thereof and all dividends, interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee and Agent for Itself, Thefacility Agent and the Lenders)
    Transactions
    • 07 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)

    CHESTER MEADOW LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 déc. 2012Commencement of winding up
    04 mai 2014Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew Dunham
    1st Floor Royal Liver Building
    L3 1PS Liverpool
    practitioner
    1st Floor Royal Liver Building
    L3 1PS Liverpool
    David Michael Riley
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    practitioner
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0