MANRESA DEVELOPMENTS LIMITED

MANRESA DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMANRESA DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04431118
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MANRESA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe MANRESA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MANRESA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour MANRESA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de 29 Great Peter Street London SW1P 3LW United Kingdom le 10 nov. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 nov. 2011

    LRESSP

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2010

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 mai 2011

    État du capital au 09 mai 2011

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicholas Anthony Christopher Candy le 09 mai 2011

    2 pagesCH01

    Nomination de Steven Miles Smith en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2009

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicholas Anthony Christopher Candy le 03 mai 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Law Store Limited le 03 mai 2010

    2 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2008

    16 pagesAA

    legacy

    7 pages363a

    legacy

    8 pages363a

    legacy

    8 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2007

    16 pagesAA

    legacy

    7 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages190

    Qui sont les dirigeants de MANRESA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAW STORE LIMITED
    Great Peter Street
    SW1P 3LW London
    29
    United Kingdom
    Secrétaire
    Great Peter Street
    SW1P 3LW London
    29
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3087477
    45735050003
    CANDY, Nicholas Anthony Christopher
    Rutland Gardens
    SW7 1BX London
    Rutland House
    United Kingdom
    Administrateur
    Rutland Gardens
    SW7 1BX London
    Rutland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish92851350008
    SIMMONDS, Gillian
    Penthouse 2
    21 Manresa Road
    SW3 6LZ London
    Administrateur
    Penthouse 2
    21 Manresa Road
    SW3 6LZ London
    EnglandBritish5062890002
    SIMMONDS, Julian Michael
    Penthouse 2
    21 Manresa Road
    SW3 6LZ London
    Administrateur
    Penthouse 2
    21 Manresa Road
    SW3 6LZ London
    United KingdomBritish27015420002
    SMITH, Steven Miles
    Braye Du Valle
    St. Sampson
    GY2 4RB Guernsey
    Hawkesbury
    Channel Isles
    Administrateur
    Braye Du Valle
    St. Sampson
    GY2 4RB Guernsey
    Hawkesbury
    Channel Isles
    GuernseyBritish62484110002
    WILLIAMS, Richard Steven
    La Longue Maison
    Rue Des Bailleuls, St. Andrews
    GY6 8XB Guernsey
    Secrétaire
    La Longue Maison
    Rue Des Bailleuls, St. Andrews
    GY6 8XB Guernsey
    British92144320002
    LAWSTORE LIMITED
    31 Warwick Square
    SW1V 2AF London
    Secrétaire
    31 Warwick Square
    SW1V 2AF London
    45735050001
    SEVERNSIDE SECRETARIAL LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Secrétaire désigné
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003990001
    CANDY, Christian Peter
    Villa Hermose
    9 Boulevard De Suisse
    FOREIGN Monaco
    980000
    Monaco
    Administrateur
    Villa Hermose
    9 Boulevard De Suisse
    FOREIGN Monaco
    980000
    Monaco
    British87803790003
    COLLIS, Paul
    Hale House
    Okewood Hill
    RH5 5NA Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Hale House
    Okewood Hill
    RH5 5NA Dorking
    Surrey
    British83062760001
    GERRARD, Anthony William
    59 Eaton Mews West
    SW1W 9ET London
    Administrateur
    59 Eaton Mews West
    SW1W 9ET London
    British65120490003
    SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Administrateur désigné
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003980001

    MANRESA DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment in security
    Créé le 18 févr. 2004
    Livré le 04 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights interests and benefits in and to the contract. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment in security
    Créé le 22 janv. 2004
    Livré le 30 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company's rights, interests and benefits in and to the contract.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 07 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy with halifax life limited on the life of paul james collis policy number: ASSH002283. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 07 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy with halifax life limited on the life of antony gerard policy number: ASSH002282. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Legal charge
    Créé le 12 juil. 2002
    Livré le 24 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the west side of manresa road and the north side of carlyle square chelsea t/n 144044 NGL15363 NGL34702 and BGL22530.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) LTD
    Transactions
    • 24 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 juil. 2002
    Livré le 22 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The f/h property k/a land and buildings on the west side of manresa road and on the north east side of carlyle square chelsea london SW3 t/n 144044 NGL15363,NGL34702 and BGL22560.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 juil. 2002
    Livré le 18 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over cash deposit
    Créé le 12 juil. 2002
    Livré le 18 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit being £3,060,000 held in the account number 304824 at hbos treasury services PLC at 155 bishopsgate london EC2M 3UB and all the present and future rights titles and benefit of the company whatsoever in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MANRESA DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 nov. 2011Commencement of winding up
    08 sept. 2012Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul Robert Appleton
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    practitioner
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0