TULA GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTULA GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04433635
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TULA GROUP LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TULA GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o EY
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TULA GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SPEED 9165 LIMITED08 mai 200208 mai 2002

    Quels sont les derniers comptes de TULA GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour TULA GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Jayne Mary Worden en tant que directeur le 11 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2019

    10 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Radley, 3rd Floor Mcbeath House 310 Goswell Road London EC1V 7LW à C/O Ey 1 More London Place London SE1 2AF le 21 févr. 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 31 janv. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 26 janv. 2018

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancellation of the share premium account and cancellation of the capital redemption reserve 25/01/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 09 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 09 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2016

    15 pagesAA

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Roger Clive Best en tant que directeur le 03 juin 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gregory Pratt en tant que secrétaire le 03 juin 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Naomi Halliday en tant que directeur le 03 juin 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nicholas James Vance en tant que directeur le 03 juin 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 févr. 2016

    État du capital au 03 févr. 2016

    • Capital: GBP 264,250
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2015

    10 pagesAA

    Nomination de Mr Justin Paul David Stead en tant qu'administrateur le 07 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Xavier Marie Olivier Simonet en tant que directeur le 08 mai 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2014

    AA

    Qui sont les dirigeants de TULA GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STEAD, Justin Paul David
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandAmerican204126530001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Secrétaire
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    British67243220003
    MURPHY, Justin Robert Anthony
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Australian71552870002
    PRATT, Gregory
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Secrétaire
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    167192940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ALLEN, Pelham Brian
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritish166398180001
    BEST, Roger Clive
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Administrateur
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandBritish114728210001
    BEST, Roger Clive
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    Administrateur
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    EnglandBritish114728210001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Administrateur
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish67243220004
    CORLETT, Anthony John Darcy
    42 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Administrateur
    42 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    United KingdomBritish37929030005
    ENEVOLDSON, Karl Thyge
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    Administrateur
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    British87906250001
    GAEDE, Sven Willi Swithin
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Administrateur
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish122640470001
    HALLIDAY, Naomi
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Administrateur
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    United KingdomBritish184787710001
    HARDER, Lowell Judith
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    Administrateur
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    UkAustralian26244220001
    LISTER, Ivan James
    14 Elmore Street
    N1 3AL London
    Administrateur
    14 Elmore Street
    N1 3AL London
    United KingdomBritish67150960004
    MURPHY, Justin Robert Anthony
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Australian71552870002
    RODRIGUES, Selwyn Mario Pius
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    Administrateur
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    British78514760004
    SIMONET, Xavier Marie Olivier
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Administrateur
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandFrench184753700001
    VANCE, Nicholas James
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Administrateur
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandBritish184753710001
    WARNER, Alan Mark
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    Administrateur
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    United KingdomBritish119324870001
    WORDEN, Jayne Mary
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish109333140001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TULA GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    06 avr. 2016
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland & Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5707910
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    TULA GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 09 déc. 2007
    Livré le 18 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become from each obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Unit 1 site b brundell drive brinklow mi. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Agent)
    Transactions
    • 18 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 12 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 10 juil. 2006
    Livré le 14 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re tula group LTD and numbered 2061452 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respectthereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 févr. 2006
    Livré le 09 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Unit 1, site b, brundell drive, brinklow, milton keynes t/n BM296212. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 09 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 21 févr. 2003
    Livré le 11 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 11 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 févr. 2003
    Livré le 28 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alan Mark Warner, Malcolm Warner, Christopher Howell and Peter Myers
    Transactions
    • 28 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 févr. 2003
    Livré le 28 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lowell Judith Harder
    Transactions
    • 28 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TULA GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2018Commencement of winding up
    12 févr. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Joseph Luke Carleton
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    practitioner
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    practitioner
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0