PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED

PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPATALEX V PRODUCTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04439612
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    250 Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LOMBARD CORPORATE FINANCE (8) LIMITED15 mai 200215 mai 2002

    Quels sont les derniers comptes de PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2021

    16 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Keith Damian Pereira le 07 sept. 2021

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Lowe le 07 sept. 2021

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2020

    16 pagesAA

    Nomination de Natwest Markets Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 29 avr. 2021

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Natwest Group Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 29 avr. 2021

    1 pagesTM02

    Modification des coordonnées du secrétaire Rbs Secretarial Services Limited le 16 sept. 2020

    1 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2019

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2018

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Lombard Corporate Finance (11) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 juil. 2017

    2 pagesPSC02

    Cessation de Royal Bank Leasing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 juil. 2017

    1 pagesPSC07

    Nomination de Mr Simon Charles Lowe en tant qu'administrateur le 26 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Paul Nixon en tant que directeur le 26 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de The Quadrangle the Promenade Cheltenham Gloucestershire GL50 1PX à 250 Bishopsgate London London EC2M 4AA le 12 avr. 2019

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Ian Andrew Ellis en tant que directeur le 08 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Keith Damian Pereira en tant qu'administrateur le 08 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Stephen Paul Nixon en tant qu'administrateur le 08 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NATWEST MARKETS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Secrétaire
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement11360457
    249447430001
    LOWE, Simon Charles
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    London
    England
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    London
    England
    EnglandBritish109835010002
    PEREIRA, Keith Damian
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    London
    England
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    London
    England
    EnglandBritish239981580001
    CHILDS, Maureen Anne
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    Secrétaire
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    British35994320001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    DOWN, Carolyn Jean
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    Secrétaire
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    Other67499700004
    THOMAS, Marina Louise
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    Secrétaire
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    British80901390001
    NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Secrétaire
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrementSC269847
    169073830002
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Administrateur
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    CATERER, Sharon Jill
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    Administrateur
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish15490360001
    CHILDS, Maureen Anne
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    Administrateur
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    EnglandBritish35994320001
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Administrateur
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritish123744930001
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    The Quadrangle
    The Promenade
    GL50 1PX Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Quadrangle
    The Promenade
    GL50 1PX Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish49141230004
    CROME, Trevor Douglas
    The Quadrangle
    The Promenade
    GL50 1PX Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Quadrangle
    The Promenade
    GL50 1PX Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish186705800001
    DEVINE, Alan Sinclair
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    British96634670001
    ELLIS, Ian Andrew
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Administrateur
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    United KingdomBritish243996550001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    GADSBY, Andrew Paul
    The Quadrangle
    The Promenade
    GL50 1PX Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Quadrangle
    The Promenade
    GL50 1PX Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish74834980002
    HARRIS, David Gerald
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    Administrateur
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    United KingdomBritish236842580001
    JOHNSON, Alan Piers
    EC2M 4RB London,
    280 Bishopsgate
    England
    Administrateur
    EC2M 4RB London,
    280 Bishopsgate
    England
    EnglandBritish155895050001
    LATTER, William Vaughan
    Mernian
    Bushley
    GL20 6HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    Mernian
    Bushley
    GL20 6HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    British52914600004
    MAYES, Emma-Marie
    The Quadrangle
    The Promenade
    GL50 1PX Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Quadrangle
    The Promenade
    GL50 1PX Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish258397370001
    MCDAID, Neil Jason
    EC2M 4RB London
    250 Bishopsgate
    England
    Administrateur
    EC2M 4RB London
    250 Bishopsgate
    England
    United KingdomBritish222279310001
    NIXON, Stephen Paul
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    EnglandBritish161010580001
    PAYNE, Brian John
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    Administrateur
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    EnglandBritish38688940001
    PEARCE, Nigel
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    Administrateur
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritish63084840002
    ROGERS, Julian Edwin
    2 The Green
    RM15 6SD South Ockendon
    Nubbock House
    Essex
    England
    Administrateur
    2 The Green
    RM15 6SD South Ockendon
    Nubbock House
    Essex
    England
    EnglandBritish137180040001
    ROULSTON, Steven James
    Ground Floor, Business House F
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn, PO BOX 1000
    Scotland
    Administrateur
    Ground Floor, Business House F
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn, PO BOX 1000
    Scotland
    ScotlandBritish238205130001
    SHEPHARD, Ian Maxwell
    Hungerford House
    Pale Lane Winchfield
    RG27 8SW Hook
    Hampshire
    Administrateur
    Hungerford House
    Pale Lane Winchfield
    RG27 8SW Hook
    Hampshire
    British111421920002
    SLATTERY, Domhnal
    16 Ailesbury Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Administrateur
    16 Ailesbury Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Republic Of IrelandIrish154385180001
    SULLIVAN, Christopher Paul
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    Administrateur
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    United KingdomBritish67033830004
    SULLIVAN, Paul Denzil John
    10 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedforedshire
    Administrateur
    10 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedforedshire
    EnglandBritish111421900001
    TUBB, Philip Anthony
    15 Mardleybury Road
    SG3 6SG Datchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    15 Mardleybury Road
    SG3 6SG Datchworth
    Hertfordshire
    British98115740001
    WARREN, Roy Francis
    Glanville Drive
    Hinton Blewett
    BS39 5GF Bristol
    4
    Avon
    Administrateur
    Glanville Drive
    Hinton Blewett
    BS39 5GF Bristol
    4
    Avon
    EnglandBritish132967870001
    WOOD, John Hamer
    Smith House, Elmwood Avenue
    TW13 7QD Feltham
    Rbs Invoice Finance
    Administrateur
    Smith House, Elmwood Avenue
    TW13 7QD Feltham
    Rbs Invoice Finance
    United KingdomBritish136006840001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Lombard Corporate Finance (11) Limited
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    11 juil. 2017
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House England & Wales
    Numéro d'enregistrement04439310
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    24/25 St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Midlothian
    Scotland
    06 avr. 2016
    24/25 St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Midlothian
    Scotland
    Oui
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 1948
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc058013
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of security assignment and charge
    Créé le 08 oct. 2004
    Livré le 21 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest in the entire copyright and all other rights in and to the picture being "derailed", all elements and any music, music compositions and recordings including lyrics, all contracts, the distribution agreement and book debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mfc Film Financing Vii, Llc
    Transactions
    • 21 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of security assignment and charge
    Créé le 08 oct. 2004
    Livré le 21 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The entire copyright and all of the chargor's other rights in and to the picture being "derailed" and all elements contained therein and any music, music compositions and/or recordings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mfc Film Productions, Llc
    Transactions
    • 21 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0