PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04439612 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 250 Bishopsgate EC2M 4AA London London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 oct. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2021 | 16 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Keith Damian Pereira le 07 sept. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Lowe le 07 sept. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2020 | 16 pages | AA | ||
Nomination de Natwest Markets Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 29 avr. 2021 | 2 pages | AP04 | ||
Cessation de la nomination de Natwest Group Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 29 avr. 2021 | 1 pages | TM02 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Rbs Secretarial Services Limited le 16 sept. 2020 | 1 pages | CH04 | ||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2019 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2018 | 17 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Notification de Lombard Corporate Finance (11) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 juil. 2017 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Royal Bank Leasing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 juil. 2017 | 1 pages | PSC07 | ||
Nomination de Mr Simon Charles Lowe en tant qu'administrateur le 26 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Stephen Paul Nixon en tant que directeur le 26 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de The Quadrangle the Promenade Cheltenham Gloucestershire GL50 1PX à 250 Bishopsgate London London EC2M 4AA le 12 avr. 2019 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Ian Andrew Ellis en tant que directeur le 08 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Keith Damian Pereira en tant qu'administrateur le 08 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Stephen Paul Nixon en tant qu'administrateur le 08 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST MARKETS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England |
| 249447430001 | ||||||||||
| LOWE, Simon Charles | Administrateur | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 London England | England | British | 109835010002 | |||||||||
| PEREIRA, Keith Damian | Administrateur | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 London England | England | British | 239981580001 | |||||||||
| CHILDS, Maureen Anne | Secrétaire | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | British | 35994320001 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Angela Mary | Secrétaire | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||||||
| DOWN, Carolyn Jean | Secrétaire | 280 Bishopsgate EC2M 4RB London 4th Floor England | Other | 67499700004 | ||||||||||
| THOMAS, Marina Louise | Secrétaire | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
| NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830002 | ||||||||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Administrateur | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||||||
| CATERER, Sharon Jill | Administrateur | The Promonade GL50 1PX Cheltenham The Quadrangle Gloucestershire England | England | British | 15490360001 | |||||||||
| CHILDS, Maureen Anne | Administrateur | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | England | British | 35994320001 | |||||||||
| CLEMETT, Graham Colin | Administrateur | 15 Winchester Close KT10 8QH Esher Surrey | United Kingdom | British | 123744930001 | |||||||||
| CLIBBENS, Nigel Timothy John | Administrateur | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 49141230004 | |||||||||
| CROME, Trevor Douglas | Administrateur | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 186705800001 | |||||||||
| DEVINE, Alan Sinclair | Administrateur | 42 Mirfield Road B91 1JD Solihull West Midlands | British | 96634670001 | ||||||||||
| ELLIS, Ian Andrew | Administrateur | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 243996550001 | |||||||||
| FARNELL, Adrian Colin | Administrateur | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | 43015720002 | |||||||||
| GADSBY, Andrew Paul | Administrateur | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 74834980002 | |||||||||
| HARRIS, David Gerald | Administrateur | EC2M 4RB London 280 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 236842580001 | |||||||||
| JOHNSON, Alan Piers | Administrateur | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | British | 155895050001 | |||||||||
| LATTER, William Vaughan | Administrateur | Mernian Bushley GL20 6HX Tewkesbury Gloucestershire | British | 52914600004 | ||||||||||
| MAYES, Emma-Marie | Administrateur | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 258397370001 | |||||||||
| MCDAID, Neil Jason | Administrateur | EC2M 4RB London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 222279310001 | |||||||||
| NIXON, Stephen Paul | Administrateur | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 | England | British | 161010580001 | |||||||||
| PAYNE, Brian John | Administrateur | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | England | British | 38688940001 | |||||||||
| PEARCE, Nigel | Administrateur | Willow Trees Hazelwood Lane CR5 3PF Chipstead Surrey | United Kingdom | British | 63084840002 | |||||||||
| ROGERS, Julian Edwin | Administrateur | 2 The Green RM15 6SD South Ockendon Nubbock House Essex England | England | British | 137180040001 | |||||||||
| ROULSTON, Steven James | Administrateur | Ground Floor, Business House F EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn, PO BOX 1000 Scotland | Scotland | British | 238205130001 | |||||||||
| SHEPHARD, Ian Maxwell | Administrateur | Hungerford House Pale Lane Winchfield RG27 8SW Hook Hampshire | British | 111421920002 | ||||||||||
| SLATTERY, Domhnal | Administrateur | 16 Ailesbury Road Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | Republic Of Ireland | Irish | 154385180001 | |||||||||
| SULLIVAN, Christopher Paul | Administrateur | Princess Way RH1 1NP Redhill 3 Surrey | United Kingdom | British | 67033830004 | |||||||||
| SULLIVAN, Paul Denzil John | Administrateur | 10 Berberry Drive MK45 5ER Flitton Bedforedshire | England | British | 111421900001 | |||||||||
| TUBB, Philip Anthony | Administrateur | 15 Mardleybury Road SG3 6SG Datchworth Hertfordshire | British | 98115740001 | ||||||||||
| WARREN, Roy Francis | Administrateur | Glanville Drive Hinton Blewett BS39 5GF Bristol 4 Avon | England | British | 132967870001 | |||||||||
| WOOD, John Hamer | Administrateur | Smith House, Elmwood Avenue TW13 7QD Feltham Rbs Invoice Finance | United Kingdom | British | 136006840001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombard Corporate Finance (11) Limited | 11 juil. 2017 | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Royal Bank Leasing Limited | 06 avr. 2016 | 24/25 St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Midlothian Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of security assignment and charge | Créé le 08 oct. 2004 Livré le 21 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right, title and interest in the entire copyright and all other rights in and to the picture being "derailed", all elements and any music, music compositions and recordings including lyrics, all contracts, the distribution agreement and book debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of security assignment and charge | Créé le 08 oct. 2004 Livré le 21 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The entire copyright and all of the chargor's other rights in and to the picture being "derailed" and all elements contained therein and any music, music compositions and/or recordings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0