PEONY LEASING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PEONY LEASING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04442275 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PEONY LEASING LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PEONY LEASING LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour PEONY LEASING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 avr. 2020 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 avr. 2019 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN à Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 25 Gresham Street London EC2V 7HN à 1 More London Place London SE1 2AF le 31 mai 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew John Kemp le 06 avr. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2017 au 29 juin 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2016 au 30 juin 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew John Kemp en tant qu'administrateur le 09 janv. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Lloyds Secretaries Limited en tant que secrétaire le 20 déc. 2016 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michelle Antoinette Angela Johnson en tant que secrétaire le 20 déc. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Owen Williams en tant que directeur le 19 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gerard Ashley Fox le 06 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Owen Williams le 06 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PEONY LEASING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLOYDS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom |
| 73512200003 | ||||||||||
| DOWSETT, Colin Graham | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | England | British | 152332230001 | |||||||||
| FOX, Gerard Ashley | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | England | British | 179100520001 | |||||||||
| KEMP, Andrew John | Administrateur | Canons House Canons Way BS1 5LL Bristol Ground Floor United Kingdom | England | British | 222042280001 | |||||||||
| GITTINS, Paul | Secrétaire | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | British | 45660860003 | ||||||||||
| JOHNSON, Michelle Antoinette Angela | Secrétaire | Floor East Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st England England | 181115810001 | |||||||||||
| LODGE, Matthew Sebastian | Secrétaire | Rose Cottage Dog Lane Stainland HX4 9QF Halifax West Yorkshire | British | 32609030001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| AITKEN, Joe | Administrateur | 19 Kettilstoun Crescent EH49 6PR Linlithgow West Lothian | British | 123316840001 | ||||||||||
| COOKE, Timothy John | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | England | British | 120834610001 | |||||||||
| CUMMING, Andrew John | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 46297770002 | |||||||||
| GLASSCOE, Keith Roderick | Administrateur | 18 Stanmore Chase AL4 0EZ St Albans Hertfordshire | British | 126272230001 | ||||||||||
| GLEDHILL, Simon Christopher | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | United Kingdom | British | 191439050001 | |||||||||
| ISAACS, Robin Alexander | Administrateur | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 115548350001 | |||||||||
| JUKES, Anthony Wilfrid | Administrateur | Potts Farm Chennell Park Lane TN30 6XA Tenterden Kent | British | 50640090001 | ||||||||||
| LIVINGSTON, Stewart Fraser | Administrateur | 86 Murrayfield Gardens EH12 6DQ Edinburgh | British | 111282080002 | ||||||||||
| MORRISSEY, John Michael | Administrateur | 66 Selborne Road Southgate N14 7DG London | England | British | 94094650001 | |||||||||
| PETERS, Stephen John | Administrateur | Old Swan Cottage 9 London Road TN16 1BB Westerham Kent | British | 56296720007 | ||||||||||
| PETERS, Stephen John | Administrateur | Old Swan Cottage 9 London Road TN16 1BB Westerham Kent | British | 56296720007 | ||||||||||
| RICHARDS, Ceri | Administrateur | Level 7 Bishopsgate Exchange 155 Bishopsgate EC2M 3YB London | British | 70624480004 | ||||||||||
| SHARP, Yvonne Easton | Administrateur | 11 Earl Grey Street EH3 9BN Edinburgh New Uberior House Midlothian Scotland | United Kingdom | British | 126272440001 | |||||||||
| SHINDLER, David Lawrence | Administrateur | 4 Berkeley Close WD6 3JN Elstree Hertfordshire | British | 92235400001 | ||||||||||
| SMALLWOOD, James Douglas Mortimer | Administrateur | 4 Chestnuts SG13 8AQ Hertford Hertfordshire | England | British | 110517930001 | |||||||||
| TOWN, Lindsay John | Administrateur | 10 Ferndale TN2 3PB Tunbridge Wells Kent | England | British | 64287260001 | |||||||||
| VELDHUIZEN, Lambertus Hendrik | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | United Kingdom | Dutch | 152683120001 | |||||||||
| WILLIAMS, Richard Owen | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | England | British | 164554190001 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PEONY LEASING LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Of Scotland Structured Asset Finance Limited | 06 avr. 2016 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
PEONY LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A hong kong ship mortgage | Créé le 17 mars 2005 Livré le 21 mars 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The vessel named oocl tianjin official number hk-1459. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A hong kong ship mortgage | Créé le 28 févr. 2005 Livré le 07 mars 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The vessel named oocl atlantic with official number hk-1458. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of covenant | Créé le 15 déc. 2004 Livré le 29 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions A 99,500 dwt (metric) container vessel known as hull no 1485 and to be named oocl atlanta, registered under the hong kong flag including any share or interest and its engines,machinery,boats,tackle,outfit,etc; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of covenant | Créé le 15 déc. 2004 Livré le 29 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions A 99,500 dwt (metric) container vessel known as hull no 1484 and to be named oocl atlanta,registered under the hong kong flag including any share or interest and its engines,machinery,boats,tackle,outfit,etc; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Hong kong ship mortgage | Créé le 30 juin 2003 Livré le 10 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The vessel named oocl long beach registered in the hong kong register of ships with official no. Hk-1017. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A hong kong ship mortgage | Créé le 29 avr. 2003 Livré le 02 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The vessel named oocl shenzhen registered in the hong kong register of ships with official number hk-1015. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| The deed of covenant | Créé le 17 avr. 2003 Livré le 02 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions A 99,500 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no.1419 And to be named oocl long beach. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| The deed of covenant | Créé le 17 avr. 2003 Livré le 02 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions A 99,500 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1418 and to be named oocl shenzhen registered or to registered under the hong kong flag.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
PEONY LEASING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0