PEONY LEASING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPEONY LEASING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04442275
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PEONY LEASING LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PEONY LEASING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PEONY LEASING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BELLBUY LIMITED20 mai 200220 mai 2002

    Quels sont les derniers comptes de PEONY LEASING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour PEONY LEASING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 avr. 2020

    10 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 avr. 2019

    9 pagesLIQ03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN à Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 25 Gresham Street London EC2V 7HN à 1 More London Place London SE1 2AF le 31 mai 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 avr. 2018

    LRESSP

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew John Kemp le 06 avr. 2018

    2 pagesCH01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2017 au 29 juin 2017

    1 pagesAA01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2016 au 30 juin 2017

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Andrew John Kemp en tant qu'administrateur le 09 janv. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Lloyds Secretaries Limited en tant que secrétaire le 20 déc. 2016

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Michelle Antoinette Angela Johnson en tant que secrétaire le 20 déc. 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Richard Owen Williams en tant que directeur le 19 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 mai 2016

    État du capital au 23 mai 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 mai 2015

    État du capital au 21 mai 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gerard Ashley Fox le 06 mars 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Owen Williams le 06 mars 2015

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de PEONY LEASING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement02791894
    73512200003
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    EnglandBritish152332230001
    FOX, Gerard Ashley
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish179100520001
    KEMP, Andrew John
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish222042280001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    JOHNSON, Michelle Antoinette Angela
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    Secrétaire
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    181115810001
    LODGE, Matthew Sebastian
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    British32609030001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AITKEN, Joe
    19 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    19 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    British123316840001
    COOKE, Timothy John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish120834610001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish46297770002
    GLASSCOE, Keith Roderick
    18 Stanmore Chase
    AL4 0EZ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    18 Stanmore Chase
    AL4 0EZ St Albans
    Hertfordshire
    British126272230001
    GLEDHILL, Simon Christopher
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish191439050001
    ISAACS, Robin Alexander
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish115548350001
    JUKES, Anthony Wilfrid
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    Administrateur
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    British50640090001
    LIVINGSTON, Stewart Fraser
    86 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Administrateur
    86 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    British111282080002
    MORRISSEY, John Michael
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    Administrateur
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    EnglandBritish94094650001
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Administrateur
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    British56296720007
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Administrateur
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    British56296720007
    RICHARDS, Ceri
    Level 7 Bishopsgate Exchange
    155 Bishopsgate
    EC2M 3YB London
    Administrateur
    Level 7 Bishopsgate Exchange
    155 Bishopsgate
    EC2M 3YB London
    British70624480004
    SHARP, Yvonne Easton
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomBritish126272440001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    British92235400001
    SMALLWOOD, James Douglas Mortimer
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritish110517930001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish64287260001
    VELDHUIZEN, Lambertus Hendrik
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomDutch152683120001
    WILLIAMS, Richard Owen
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish164554190001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PEONY LEASING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02279167
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PEONY LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A hong kong ship mortgage
    Créé le 17 mars 2005
    Livré le 21 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The vessel named oocl tianjin official number hk-1459.
    Personnes ayant droit
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transactions
    • 21 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A hong kong ship mortgage
    Créé le 28 févr. 2005
    Livré le 07 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The vessel named oocl atlantic with official number hk-1458.
    Personnes ayant droit
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transactions
    • 07 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenant
    Créé le 15 déc. 2004
    Livré le 29 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A 99,500 dwt (metric) container vessel known as hull no 1485 and to be named oocl atlanta, registered under the hong kong flag including any share or interest and its engines,machinery,boats,tackle,outfit,etc; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transactions
    • 29 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenant
    Créé le 15 déc. 2004
    Livré le 29 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A 99,500 dwt (metric) container vessel known as hull no 1484 and to be named oocl atlanta,registered under the hong kong flag including any share or interest and its engines,machinery,boats,tackle,outfit,etc; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transactions
    • 29 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Hong kong ship mortgage
    Créé le 30 juin 2003
    Livré le 10 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The vessel named oocl long beach registered in the hong kong register of ships with official no. Hk-1017.
    Personnes ayant droit
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transactions
    • 10 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    A hong kong ship mortgage
    Créé le 29 avr. 2003
    Livré le 02 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The vessel named oocl shenzhen registered in the hong kong register of ships with official number hk-1015.
    Personnes ayant droit
    • Orient Overseas Container Line (U.K) Limited
    Transactions
    • 02 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    The deed of covenant
    Créé le 17 avr. 2003
    Livré le 02 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A 99,500 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no.1419 And to be named oocl long beach. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Orient Overseas Container Line (UK) Limited
    Transactions
    • 02 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    The deed of covenant
    Créé le 17 avr. 2003
    Livré le 02 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A 99,500 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1418 and to be named oocl shenzhen registered or to registered under the hong kong flag.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Orient Overseas Container Line (U.K) Limited
    Transactions
    • 02 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    PEONY LEASING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 avr. 2018Commencement of winding up
    22 janv. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0