LEXINGTON ENGINEERING LIMITED

LEXINGTON ENGINEERING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLEXINGTON ENGINEERING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04445049
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LEXINGTON ENGINEERING LIMITED ?

    • (7132) /

    Où se situe LEXINGTON ENGINEERING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St. Annes
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LEXINGTON ENGINEERING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    P G PRECISION TOOLMAKERS LIMITED20 janv. 200420 janv. 2004
    CURRAN FORMWORK LIMITED22 mai 200222 mai 2002

    Quels sont les derniers comptes de LEXINGTON ENGINEERING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour LEXINGTON ENGINEERING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    Changement d'adresse du siège social de Unit 1 Mill Green Road Mitcham Surrey CR4 4HZ le 10 nov. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Report de la dissolution

    1 pagesL64.04

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    1 pagesCOCOMP

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2006

    3 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2005

    3 pagesAA

    Comptes modifiés jusqu'au 31 mai 2004

    3 pagesAAMD

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    31 pages395

    legacy

    51 pages395

    legacy

    15 pages395

    legacy

    6 pages363s

    Comptes établis au 31 mai 2004

    1 pagesAA

    legacy

    3 pages395

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages395

    legacy

    11 pages395

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de LEXINGTON ENGINEERING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HAINES, Brian Richard
    55 Leckford Road
    SW19 3PT London
    Secrétaire
    55 Leckford Road
    SW19 3PT London
    British115453700001
    SWAIN, Linda Louise
    35 Orleans Court
    Seymour Gardens
    TW1 3AP Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    35 Orleans Court
    Seymour Gardens
    TW1 3AP Twickenham
    Middlesex
    British40782080001
    SAUL, Mark Ashley
    Willow Garth
    Fieldhouse Close
    LS22 6UD Wetherby
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Willow Garth
    Fieldhouse Close
    LS22 6UD Wetherby
    West Yorkshire
    British65736880002
    SWAIN, Linoa Louise
    35 Orleans Court
    TW1 3AP Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    35 Orleans Court
    TW1 3AP Twickenham
    Middlesex
    British92897500001
    ASHBURTON REGISTRARS LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Secrétaire désigné
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014760001
    ASHWAY ACCOUNTANTS LIMITED
    Willow Garth
    Field House Close
    LS22 6UD Wetherby
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Willow Garth
    Field House Close
    LS22 6UD Wetherby
    West Yorkshire
    96119620001
    ASHWAY SECRETATIAL SERVICES LTD
    1 Field House Close
    LS22 6UD Wetherby
    West Yorkshire
    Secrétaire
    1 Field House Close
    LS22 6UD Wetherby
    West Yorkshire
    99452750001
    SAUL, Mark Ashley
    Willow Garth
    Fieldhouse Close
    LS22 6UD Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Willow Garth
    Fieldhouse Close
    LS22 6UD Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish65736880002
    AR NOMINEES LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Administrateur désigné
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014750001

    LEXINGTON ENGINEERING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of master assignment
    Créé le 13 oct. 2005
    Livré le 15 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for itself and each associate) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights and interests in any sub-hire agreements and in any sub-hire rentals. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • State Securities PLC
    Transactions
    • 15 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental chattel mortgage
    Créé le 23 sept. 2005
    Livré le 05 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the non vesting assets being, hitachi seiki hitec turn 23RIII c axis cnc turning centre, hitachi seiki hi cell 23II 4 axis cnc turning centre, trimos vertical 3 digital gauge, for details of further chattels charged please refer to form 395, together with the benefit of all existing guarantees, warranties and servicing and maintenance agreements and intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • State Securities PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental chattel mortgage
    Créé le 23 sept. 2005
    Livré le 05 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the non-vesting assets being, hitachi seiki hitec turn 25S cnc lathe, hitachi seiki hitec turn 25G cnc turning centre, hardinge conquest CS42 cnc slant bed lathe, for details of further chattels charged please refer to form 395, together with the benefit of all existing guarantees, warranties and servicing and maintenance agreements and intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • State Securities PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental chattel mortgage
    Créé le 20 déc. 2004
    Livré le 23 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Robofil 2030SI-tw yom 2001 s/n 124616, robofil 440 cc wire edm machining centre yom 2003 s/n 931140, actspark SD1 cnc hole drilling machine yom 2003 s/n 015-009 for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • State Securities PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental chattel mortgage
    Créé le 02 juil. 2004
    Livré le 07 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Cnc universal cylindrical grinding machine S31 cnc series 50; cnc universal cylindrical grinding machine S31 cnc series 46, mikron VCE600 pro ex demonstration milling machine yom june 2002, for details of further chattels charged please refer to form 395.
    Personnes ayant droit
    • State Securities PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 02 juil. 2004
    Livré le 07 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any associate, under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • State Securities PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)

    LEXINGTON ENGINEERING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 févr. 2014Dissolved on
    16 mars 2007Petition date
    20 nov. 2013Conclusion of winding up
    06 juin 2007Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    practitioner
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    James Richard Duckworth
    Freeman Rich
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St Annes
    Lancashire
    practitioner
    Freeman Rich
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St Annes
    Lancashire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0