PLS GRP LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PLS GRP LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04446608 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PLS GRP LTD ?
| Adresse du siège social | Unit 1 Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Essex England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PLS GRP LTD ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour PLS GRP LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 044466080007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter David Mawby Smith le 13 oct. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
État du capital au 28 sept. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Modification des détails de Pls Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 avr. 2020 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2019 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Peter David Mawby Smith en tant qu'administrateur le 01 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Mcmahon en tant que directeur le 30 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018 | 8 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de St James House C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor St James Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR United Kingdom à Unit 1 Yardley Business Park Luckyn Lane Basildon Essex SS14 3BZ le 09 avr. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 044466080006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Inscription de la charge 044466080007, créée le 19 déc. 2018 | 69 pages | MR01 | ||||||||||
Nomination de Mr John William Charles Charlton en tant qu'administrateur le 12 déc. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Stuart More en tant que directeur le 25 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy John Cobbett Simpson en tant que directeur le 15 oct. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 King George Close Romford Essex RM7 7LS United Kingdom à St James House C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor St James Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR le 11 mai 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PLS GRP LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLTON, John William Charles | Secrétaire | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | 230737840001 | |||||||
| CHARLTON, John William Charles | Administrateur | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | England | British | 119598150002 | |||||
| SMITH, Peter David Mawby | Administrateur | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | England | British | 159286600004 | |||||
| FOLEY, Vernon | Secrétaire | 10 Upminister Trading Park Warley Street RM14 3PJ Upminster Precision House Essex | Other | 63884920003 | ||||||
| HOWELL, Simon John | Secrétaire | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | 203678890001 | |||||||
| MORE, Danielle Lynne | Secrétaire | 37 Stewart Avenue RM14 2AE Upminster Essex | British | 27590340002 | ||||||
| CARLTON BAKER CLARKE SECRETARIES LTD | Secrétaire | Suite 1 South House Lodge Off Mundon Road CM9 6PP Maldon Essex | 89540400006 | |||||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Secrétaire désigné | 39a Leicester Road M7 4AS Salford | 900014920001 | |||||||
| THE BAKER PARTNERSHIP (UK) SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | South House Lodge Off Mundon Road CM9 6PP Maldon Suite 1 Essex England | 129716590001 | |||||||
| BIRRANE, Sean Thomas | Administrateur | King George Close Romford RM7 7LS Essex 1 United Kingdom | England | British | 101296120004 | |||||
| BLACK, Stuart John | Administrateur | King George Close Romford RM7 7LS Essex 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 49053310001 | |||||
| LOWERY, Steven Robert | Administrateur | 31 Highview Gardens RM14 2YU Upminster Essex | United Kingdom | British | 82281070002 | |||||
| MCMAHON, Michael | Administrateur | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | United Kingdom | British | 173928090001 | |||||
| MORE, Graham Stuart | Administrateur | C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor St James Square GL50 3PR Cheltenham St James House Gloucestershire United Kingdom | England | British | 56850320003 | |||||
| SIMPSON, Jeremy John Cobbett | Administrateur | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 187009310001 | |||||
| FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Administrateur désigné | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester | 900014990001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PLS GRP LTD ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pls Holdings Limited | 30 juin 2016 | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
PLS GRP LTD a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 19 déc. 2018 Livré le 24 déc. 2018 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 20 oct. 2016 Livré le 21 oct. 2016 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 10 sept. 2014 Livré le 10 sept. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description A fixed and floating charge over all assets. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 07 juin 2006 Livré le 14 juin 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a 10 upminster trading park, warley street, upminster, essex t/n EX569555. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 07 juin 2006 Livré le 14 juin 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 18 nov. 2002 Livré le 20 nov. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold property known as unit 10 upminster trading park,warley st,upminster,essex; ex 569555. with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 nov. 2002 Livré le 15 nov. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0