BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED

BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04448005
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ELITEDEGREE LIMITED27 mai 200227 mai 2002

    Quels sont les derniers comptes de BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 avr. 2016

    18 pages2.24B

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration

    19 pages2.33B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 15 févr. 2016

    21 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 15 août 2015

    20 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 15 févr. 2015

    18 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 15 févr. 2015

    18 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 15 févr. 2015

    18 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 15 août 2014

    21 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 15 févr. 2014

    21 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 30 sept. 2013

    21 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 18 avr. 2013

    21 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Cessation de la nomination de Benjamin Broader en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    52 pages2.17B

    legacy

    53 pagesMG06

    Qui sont les dirigeants de BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ACCOMPLISH SECRETARIES LIMITED
    South Street
    Mayfair
    W1K 1DG London
    18
    Secrétaire
    South Street
    Mayfair
    W1K 1DG London
    18
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5752036
    121109170001
    GODDARD, James Michael
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    British70168860001
    HANSON, Tracey Anna Marie
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    Secrétaire
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    British64264570001
    MURPHY, Dominic Patrick
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    British82500670001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    WISEBET LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Secrétaire
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023340001
    BOAG, Timothy John Donald
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    Administrateur
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    British62111350002
    BROADER, Benjamin
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    IsraelBritish165999470001
    CLARKE, Jonathan George Gough
    Westland Farm
    Ockley Road
    GU6 7SL Ewhurst
    Surrey
    Administrateur
    Westland Farm
    Ockley Road
    GU6 7SL Ewhurst
    Surrey
    British72712910001
    GILBERT, Paul John Thomas
    Oldfield
    St Mary's Road
    WA14 2PJ Bowden
    Cheshire
    Administrateur
    Oldfield
    St Mary's Road
    WA14 2PJ Bowden
    Cheshire
    EnglandBritish149769990001
    GODDARD, James Michael
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish70168860001
    HANSON, Tracey Anna Marie
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    Administrateur
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    British64264570001
    MACNAUGHTON, Robert Magnus
    High Tong Lodge
    Marle Place Road
    TN12 7HS Brenchley
    Kent
    Administrateur
    High Tong Lodge
    Marle Place Road
    TN12 7HS Brenchley
    Kent
    British66538980003
    MACRAE, Gregor Charles William
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    Administrateur
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritish151235850002
    MURPHY, Dominic Patrick
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritish82500670001
    MURRAY, Sean Anthony
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    Administrateur
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritish67091270001
    ROBINSON, Philip Thomas
    11 Kennedy Close
    BR5 1HP Orpington
    Kent
    Administrateur
    11 Kennedy Close
    BR5 1HP Orpington
    Kent
    British72559430001
    RUDGE, David
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    Administrateur
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritish58543980004
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    ULTRALINK LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Administrateur
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023330001
    WISEBET LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Administrateur
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023340001

    BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental third party security
    Créé le 11 juil. 2008
    Livré le 17 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Sheffield arundel gate the land more particularly described in a supplemental lease between cordwell (pond street) limited (1) and bishopsgate parking (no.2) limited (2) dated 11 july 2008 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Specialised Property Investments Limited (Formerly Rbs Hotel Investments (No.2) Limited)
    Transactions
    • 17 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental debenture
    Créé le 11 juil. 2008
    Livré le 17 juil. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, senior beneficiaries and stretch senior beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Sheffield arundel gate the land more particularly described in a supplemental lease between cordwell (pond street) limited (1) and bishopsgate parking (no.2) limited (2) dated 11 july 2008 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental debenture
    Créé le 11 juil. 2008
    Livré le 17 juil. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, senior beneficiaries and stretch senior beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Sheffield arundel gate the land more particularly described in a supplemental lease between cordwell (pond street) limited (1) and bishopsgate parking (no.2) limited (2) dated 11 july 2008 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2005
    Livré le 16 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the senior beneficiaries, the stretch senior beneficiaries, the mezzanine beneficiaries, the hillstep senior beneficiaries the hillstep stretch senior beneficiaries and the hillstep mezzanine beneficiaries on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    No. 2 aldersgate lh t/no. NGL705135: no. 8 berners st lh t/no. LN192051 and LN191912: no. 12 birmingham horsefair fh t/no. WM427086 please see form for further details of property charged. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The “Security Trustee”)
    Transactions
    • 16 mars 2005
    Third party security
    Créé le 17 nov. 2003
    Livré le 05 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from powerfocal to the beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The l/h property k/a no 2 aldersgate, t/n NGL705135, the l/h property k/a no 8 berners st, t/ns LB192051 and LN191912, the f/h property k/a no 12 birmingham horsefair, t/n WM427086, see schedule attached to form 395 for other properties charged, the interest in the sale agreements, the occupational leases, the licences, the managing agent's agreement, the head leases, the tax deeds and all agreements in which BPL2 has an interest;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Hotel Investments (No.2) Limited (the Beneficiary)
    Transactions
    • 05 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 nov. 2003
    Livré le 05 déc. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, the stretch senior beneficiaries and the senior beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Non-recourse legal charge
    Créé le 17 nov. 2003
    Livré le 04 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H land known as the two storey underground car park beneath part of the north garden cadogan place chelsea london SW1X 9SA and the land below the car park together with the roof the access ramp and the fire escape staircases the ventilation extract and its housing and the smoke extracts above the roof of the car park. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Non-recourse legal charge by trustees
    Créé le 17 nov. 2003
    Livré le 02 déc. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H land known as the two storey underground car park beneath part of the north garden cadogan place chelsea london SW1X 9SA and the land below the car park together with the roof the access ramp and the fire escape staircases the ventilation extract and its housing and the smoke extracts above the roof of the car park. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Hotel Investments (No. 2) Limited
    Transactions
    • 02 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Lightweight floating charge
    Créé le 12 sept. 2003
    Livré le 23 sept. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due rom the obligors to the mezzanine beneficiaries and the stretch senior beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the assets property and undertaking of the chargor both present and future including all its goodwill and uncalled capital for the time being. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)

    BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 avr. 2016Administration ended
    19 oct. 2012Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DateType
    09 mars 2016Petition date
    22 nov. 2016Conclusion of winding up
    11 avr. 2016Commencement of winding up
    05 mars 2017Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    practitioner
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Neville Barry Kahn
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0