NORTH LAKES FOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORTH LAKES FOODS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04451152
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORTH LAKES FOODS LIMITED ?

    • Production de lait et de crème liquide (10511) / Industries manufacturières

    Où se situe NORTH LAKES FOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NORTH LAKES FOODS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GREENGILL LIMITED13 nov. 200213 nov. 2002
    GWECO 180 LIMITED30 mai 200230 mai 2002

    Quels sont les derniers comptes de NORTH LAKES FOODS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 oct. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 juil. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NORTH LAKES FOODS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au29 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation13 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au29 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour NORTH LAKES FOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 oct. 2023

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 oct. 2022

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Ian Richard Simpson en tant que directeur le 30 juin 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Miss Stacey Ann Croft en tant qu'administrateur le 19 mai 2023

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 oct. 2021

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2022 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 044511520010 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 044511520011 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Michael Brian Doyle en tant que directeur le 01 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 044511520013, créée le 30 juil. 2021

    19 pagesMR01

    Inscription de la charge 044511520012, créée le 30 juil. 2021

    14 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2021 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jonathon Parker le 21 avr. 2021

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Parker le 21 avr. 2021

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 oct. 2020

    12 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 oct. 2019

    12 pagesAA

    Nomination de Mr Anthony Parker en tant qu'administrateur le 12 juin 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 juil. 2019 au 31 oct. 2019

    1 pagesAA01

    Ordonnance du tribunal

    S1096 Court Order to Rectify
    2 pagesOC

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 oct. 2018

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    pagesANNOTATION

    Qui sont les dirigeants de NORTH LAKES FOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PARKER, Janice
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    Secrétaire
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    214207020001
    CROFT, Stacey Ann
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    Greencroft Milk Supplies
    United Kingdom
    Administrateur
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    Greencroft Milk Supplies
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector309584900001
    PARKER, Anthony
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    Greencroft Milk Supplies Limited
    Cleveland
    United Kingdom
    Administrateur
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    Greencroft Milk Supplies Limited
    Cleveland
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector270717270002
    PARKER, Derek
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    Administrateur
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    EnglandBritishDirector39473510003
    PARKER, Janice
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    Administrateur
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    EnglandBritishDirector And Company Secretary231626310001
    PARKER, Jonathon
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    Administrateur
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    EnglandBritishDirector238714380002
    DENT, Christina Heather
    Greengill
    CA11 8SE Penrith
    Cumbria
    Secrétaire
    Greengill
    CA11 8SE Penrith
    Cumbria
    BritishFarmer109006860001
    DENT, Karen Yvonne
    Maidenhill
    Penrith
    CA11 8SQ Cumbria
    Secrétaire
    Maidenhill
    Penrith
    CA11 8SQ Cumbria
    BritishFarmer87298390001
    JACKSON, George Wayne
    Gilwilly Road
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BL Penrith
    North Lakes Foods Limited
    Cumbria
    England
    Secrétaire
    Gilwilly Road
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BL Penrith
    North Lakes Foods Limited
    Cumbria
    England
    184864930001
    GWECO SECRETARIES LIMITED
    14 Piccadilly
    BD1 3LX Bradford
    West Yorkshire
    Secrétaire désigné
    14 Piccadilly
    BD1 3LX Bradford
    West Yorkshire
    900024100001
    DENT, Christina Heather
    Greengill
    CA11 8SE Penrith
    Cumbria
    Administrateur
    Greengill
    CA11 8SE Penrith
    Cumbria
    EnglandBritishFarmer109006860001
    DENT, Thomas Hugh
    Maidenhill Farm
    Maidenhill
    CA11 8SQ Penrith
    Cumbria
    Administrateur
    Maidenhill Farm
    Maidenhill
    CA11 8SQ Penrith
    Cumbria
    EnglandBritishFarmer87760930001
    DENT, Thomas Gordon
    Greengill Farm
    Greengill
    CA11 8SE Penrith
    Cumbria
    Administrateur
    Greengill Farm
    Greengill
    CA11 8SE Penrith
    Cumbria
    EnglandBritishFarmer87760880001
    DOYLE, Michael Brian
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    Administrateur
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    EnglandBritishDirector170635600002
    JACKSON, George Wayne
    Gilwilly Road
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BL Penrith
    North Lakes Foods Limited
    Cumbria
    England
    Administrateur
    Gilwilly Road
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BL Penrith
    North Lakes Foods Limited
    Cumbria
    England
    EnglandBritishCompany Director184864940001
    JACKSON, Robert Denver
    Gilwilly Road
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BL Penrith
    North Lakes Foods Limited
    Cumbria
    England
    Administrateur
    Gilwilly Road
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BL Penrith
    North Lakes Foods Limited
    Cumbria
    England
    United KingdomBritishCompany Director184864980001
    SIMPSON, Ian Richard
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    Administrateur
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    C/O Greencroft Milk Supplies Ltd
    England
    United KingdomBritishDirector81603040001
    GWECO DIRECTORS LIMITED
    14 Piccadilly
    BD1 3LX Bradford
    Administrateur désigné
    14 Piccadilly
    BD1 3LX Bradford
    900024090001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NORTH LAKES FOODS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Greencroft Milk Supplies Ltd
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    Greencroft Milk Supplies Ltd
    United Kingdom
    09 sept. 2016
    Telford Road
    TS3 8BL Middlesbrough
    Greencroft Milk Supplies Ltd
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement02929752
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    NORTH LAKES FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 30 juil. 2021
    Livré le 20 août 2021
    En cours
    Brève description
    Unit 53 gilwilly road, gilwilly industrial estate, penrith, CA11 9BL registered at the land registry under title number CU170738; unit 54 gilwilly road, gilwilly industrial estate, penrith, CA11 9BL registered at the land registry under title number CU127869 and; unit 55 gilwilly road, gilwilly industrial estate, penrith, CA11 9BL registered at the land registry under title number CU55706;.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Atom Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 juil. 2021
    Livré le 19 août 2021
    En cours
    Brève description
    Unit 53 gilwilly road, gilwilly industrial estate, penrith, CA11 9BL registered at the land registry under title number CU170738; unit 54 gilwilly road, gilwilly industrial estate, penrith, CA11 9BL registered at the land registry under title number CU127869 and; unit 55 gilwilly road, gilwilly industrial estate, penrith, CA11 9BL registered at the land registry under title number CU55706.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Atom Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 03 avr. 2017
    Livré le 04 avr. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The freehold property known as 54 gilwilly industrial estate, gilwilly road, penrith (title number CU127869).
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 21 janv. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 03 avr. 2017
    Livré le 04 avr. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The freehold property known as 53 gilwilly industrial estate, gilwilly road, penrith (title number CU170738).
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 21 janv. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 15 févr. 2017
    Livré le 20 févr. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 10 févr. 2017
    Livré le 20 févr. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 20 sept. 2013
    Livré le 20 sept. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance LTD
    Transactions
    • 20 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 05 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or dent to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 15 nov. 2006
    Livré le 22 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a regent garage gilwilly trading estate penrith and the beacon dairy gilwilly road penrith cumbria t/no CU55706, CU127869.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 oct. 2005
    Livré le 05 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 06 juil. 2005
    Livré le 21 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 29 janv. 2003
    Livré le 31 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as greengill limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 janv. 2003
    Livré le 31 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as greengill limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 54 gilwilly industrial estate penrith cumbria. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0