HALLCO 762 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHALLCO 762 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04453671
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HALLCO 762 LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe HALLCO 762 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lanmor House
    370-386 High Road
    HA9 6AX Wembley
    Middlesex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HALLCO 762 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour HALLCO 762 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 06 juin 2017

    2 pages3.6

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 11 déc. 2016

    2 pages3.6

    Cessation de la nomination de Thomas Frederick Teviot Harrison en tant que directeur le 30 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 11 juin 2016

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 11 déc. 2015

    2 pages3.6

    Cessation de la nomination de Neil Alan Quinsey en tant que directeur le 05 juin 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neil Alan Quinsey en tant que secrétaire le 05 juin 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Stuart John James Cruden Gray en tant que directeur le 19 mars 2015

    1 pagesTM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 juil. 2014

    État du capital au 04 juil. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mr Stuart John James Cruden Gray en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Alan Quinsey le 01 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Neil Alan Quinsey en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Malcolm Robson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes établis au 31 mars 2013

    12 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de HALLCO 762 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    QUINSEY, Neil Alan
    House
    370-386 High Road
    HA9 6AX Wembley
    Lanmor
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    370-386 High Road
    HA9 6AX Wembley
    Lanmor
    Middlesex
    United Kingdom
    British139110160001
    ROBSON, Malcolm Henry
    65 Bury Street
    NR2 2DL Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    65 Bury Street
    NR2 2DL Norwich
    Norfolk
    BritishSecretary Director6205710001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Secrétaire désigné
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    BIZLEY, Stuart Michael
    16 Chestnut Road
    Scarning
    NR19 2TA Dereham
    Norfolk
    Administrateur
    16 Chestnut Road
    Scarning
    NR19 2TA Dereham
    Norfolk
    EnglandBritishChartered Surveyor93403500001
    GRAY, Stuart John James Cruden
    House
    370-386 High Road
    HA9 6AX Wembley
    Lanmor
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    370-386 High Road
    HA9 6AX Wembley
    Lanmor
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor186885670001
    HARRISON, Thomas Frederick Teviot
    House
    370-386 High Road
    HA9 6AX Wembley
    Lanmor
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    370-386 High Road
    HA9 6AX Wembley
    Lanmor
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector81581440001
    QUINSEY, Neil Alan
    House
    370-386 High Road
    HA9 6AX Wembley
    Lanmor
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    370-386 High Road
    HA9 6AX Wembley
    Lanmor
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director184919650001
    ROBSON, Malcolm Henry
    House
    370-386 High Road
    HA9 6AX Wembley
    Lanmor
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    370-386 High Road
    HA9 6AX Wembley
    Lanmor
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishSecretary Director6205710001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Administrateur désigné
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    HALLCO 762 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 30 sept. 2011
    Livré le 06 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any secured party on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land lying to the east of horsleys chase kings lynn t/no NK280524 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) thereon all other interest in any f/h or l/h property all proceeds of sale the benefit of all warranties and covenants and all licences rental income and occupational leases see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent for Itself and the Other Finance Parties (Security Agent)
    Transactions
    • 06 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 117 déc. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 116 févr. 2017Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 111 déc. 2019Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 1
    Debenture
    Créé le 18 août 2011
    Livré le 02 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor or any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent for Itself and the Other Finance Parties (Security Agent)
    Transactions
    • 02 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 231 déc. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 216 févr. 2017Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 208 juin 2017Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 2
    Legal charge
    Créé le 15 nov. 2007
    Livré le 23 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land being land lying on the west side of horsley's close king's lynn t/no NK280524. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 19 juin 2003
    Livré le 26 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the west side of horsley's close kings lynn t/n KN280524.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 juin 2003
    Livré le 26 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    HALLCO 762 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Allan Watson Graham
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    receiver manager
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Robert Andrew Croxen
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    receiver manager
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Allan Watson Graham
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    receiver manager
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Robert Andrew Croxen
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    receiver manager
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0