HALFORDS HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | HALFORDS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04457288 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HALFORDS HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O TENEO FINANCIAL ADVISORY LIMITED 156 Great Charles Street B3 3HN Birmingham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HALFORDS HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 03 avr. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour HALFORDS HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 14 pages | LIQ13 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Icknield Street Drive Washford West Redditch Worcestershire B98 0DE | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Icknield Street Drive Washford West Redditch Worcestershire B98 0DE | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Icknield Street Drive Washford West Redditch Worcestershire B98 0DE à 156 Great Charles Street Birmingham B3 3HN le 09 févr. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 8 pages | LIQ01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
État du capital au 18 oct. 2021
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de Karen Bellairs en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2021 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Keith Williams en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2021 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Notification de Halfords Holdings (2006) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2021 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Thomas Daniel Singer en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2021 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Keith Jones en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2021 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Helen Victoria Jones en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2021 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Jill Caseberry en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2021 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 01 avr. 2021
| 4 pages | SH01 | ||||||||||
Cessation de David Alexander Robertson Adams en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 déc. 2020 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham Barry Stapleton le 20 nov. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 03 avr. 2020 | 22 pages | AA | ||||||||||
Notification de Thomas Daniel Singer en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 sept. 2020 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HALFORDS HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard | Secrétaire | Great Charles Street B3 3HN Birmingham 156 | 204498010001 | |||||||
STAPLETON, Graham Barry | Administrateur | Washford West B98 0DE Redditch Icknield Street Drive England England | England | British | Director | 242059060002 | ||||
WOODHOUSE, Loraine | Administrateur | Washford West B98 0DE Redditch Icknield Street Drive England England | England | British | Finance Director | 134205550001 | ||||
CARTER, Nicholas Michael | Secrétaire | Laverton House Laverton WR12 7NA Broadway Worcs | British | Director | 120830070001 | |||||
EAST, Anna | Secrétaire | 203 Moor Green Lane Moseley B13 8NT Birmingham West Midlands | British | Solicitor | 109685230001 | |||||
HENDERSON, Charles Alex | Secrétaire | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | British | 193834750001 | ||||||
PARKER, Philip Alexander | Secrétaire | 4 Loveday Drive CV32 6HZ Leamington Spa Warwickshire | British | 202472990003 | ||||||
RICHARDS, Justin Mark | Secrétaire | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | 188420070001 | |||||||
SAVILLE, Richard Cyril Campbell | Secrétaire | Fairings Valley Way SL9 7PL Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Company Director | 38530070001 | |||||
TYRRELL, Helen | Secrétaire | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | 203450540001 | |||||||
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
CARTER, Nicholas Michael | Administrateur | Laverton House Laverton WR12 7NA Broadway Worcs | England | British | Director | 120830070001 | ||||
DAVIES, Matthew Samuel | Administrateur | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | England | British | Director | 180589630001 | ||||
FEUER, Jonathan Philip | Administrateur | Maytrees Granville Road KT13 0QG Weybridge Surrey | England | British | Director | 142718980001 | ||||
FINDLAY, Andrew Robert | Administrateur | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | United Kingdom | British | Director | 159858800001 | ||||
HAMID, David | Administrateur | Lower Court Three Houses Lane SG4 8TB Codicote Hertfordshire | England | British | Director | 16875700002 | ||||
HAMID, David | Administrateur | Lower Court Three Houses Lane SG4 8TB Codicote Hertfordshire | England | British | Director | 16875700002 | ||||
HILL, Robert David | Administrateur | 23 Bowers Way AL5 4EP Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 97917690001 | ||||
LOVERING, John David | Administrateur | 91 Wimpole Street W1G 0EF London | United Kingdom | British | Director | 73573160004 | ||||
LUCAS, Robert Richard | Administrateur | AL6 | British | Director | 70329570002 | |||||
MACKENZIE, Alexander Donald | Administrateur | Shalden Lodge Shalden Lane Shalden GU34 4DU Alton Hampshire | United Kingdom | British | Director | 105120270001 | ||||
MASON, Jonathan Peter | Administrateur | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | United Kingdom | British | Finance Director | 117783520001 | ||||
MCCLENAGHAN, Paul Thomas | Administrateur | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Halfords Ltd Worcestershire | England | British | Director | 136252450001 | ||||
MCDONALD, Gillian Clare | Administrateur | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | England | British | Chief Executive | 197605800002 | ||||
MCLEOD, Ian James Winward | Administrateur | Kirkby Grange Cottage Kirkby Grange Clough Road WF4 4AQ Flockton West Yorkshire | British | Director | 94445270001 | |||||
SAVILLE, Richard Cyril Campbell | Administrateur | Fairings Valley Way SL9 7PL Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Company Director | 38530070001 | ||||
SCRIBBINS, Rod | Administrateur | The Hemploe Hemploe Road NN6 6HF Welford Northamptonshire | British | Company Director | 83504910001 | |||||
TEMPLEMAN, Robert William | Administrateur | 91 Wimpole Street W1G 0EF London | Uk | British | Director | 88293210002 | ||||
WHARTON, Nicholas Barry Edward | Administrateur | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Halfords Ltd Worcestershire | Uk | Uk | Director | 77019110004 | ||||
WILD, David James | Administrateur | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Halfords Limited Worcestershire | England | British | None | 27211140003 | ||||
WOODHOUSE, Christopher Kevin | Administrateur | 91 Wimpole Street W1G 0EF London | Uk | British | Director | 48827150005 | ||||
PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Administrateur | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76332110001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HALFORDS HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halfords Holdings (2006) Limited | 01 juin 2021 | Washford West B98 0DE Redditch Icknield Street Drive United Kingdom | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Mr Thomas Daniel Singer | 16 sept. 2020 | Washford West B98 0DE Redditch Icknield Street Drive England England | Oui | ||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Keith Jones | 21 oct. 2019 | Washford West B98 0DE Redditch Icknield Street Drive England England | Oui | ||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Karen Bellairs | 17 oct. 2019 | Washford West B98 0DE Redditch Icknield Street Drive England England | Oui | ||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Ms Jill Caseberry | 01 mars 2019 | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | Oui | ||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Mr Keith Williams | 24 juil. 2018 | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | Oui | ||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Mrs Helen Victoria Jones | 30 juin 2016 | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | Oui | ||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Mr David Alexander Robertson Adams | 30 juin 2016 | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | Oui | ||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Mrs Claudia Isobel Arney | 30 juin 2016 | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | Oui | ||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Mr Dennis Henry Millard | 30 juin 2016 | Icknield Street Drive Washford West B98 0DE Redditch Worcestershire | Oui | ||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||
Nature du contrôle
|
HALFORDS HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Supplemental debenture | Créé le 07 nov. 2003 Livré le 21 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental debenture | Créé le 30 août 2002 Livré le 09 sept. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 25 juil. 2002 Livré le 07 août 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
HALFORDS HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0