DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED

DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04457527
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Notification de Development Securities (Investments) Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 29 févr. 2016

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Charles Julian Barwick en tant que directeur le 07 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juin 2016

    État du capital au 29 juin 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Michael Henry Marx en tant que directeur le 29 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard Upton en tant qu'administrateur le 08 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Charles Julian Barwick le 09 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Henry Marx le 09 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew Simon Weiner le 09 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Marcus Owen Shepherd le 09 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Chris Barton le 09 nov. 2015

    1 pagesCH03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2015

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Portland House Bressenden Place London SW1E 5DS à 7a Howick Place London SW1P 1DZ le 11 nov. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 août 2015

    État du capital au 11 août 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Mr Chris Barton en tant que secrétaire le 05 janv. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Marcus Owen Shepherd en tant que secrétaire le 05 janv. 2015

    1 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2014

    3 pagesAA

    Nomination de Mr Marcus Owen Shepherd en tant que secrétaire le 01 sept. 2014

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Helen Maria Ratsey en tant que secrétaire le 01 sept. 2014

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juin 2014

    État du capital au 23 juin 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Charles Julian Barwick le 15 avr. 2014

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Secrétaire
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    193873910001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Administrateur
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector41925000005
    UPTON, Richard
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Administrateur
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector204950320001
    WEINER, Matthew Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Administrateur
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor72888710002
    LANES, Stephen Alec
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    Secrétaire
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    BritishAccountant1266100003
    RATSEY, Helen Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    Secrétaire
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    British158458340001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    Secrétaire
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    190659860001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secrétaire désigné
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    BARWICK, Charles Julian
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Administrateur
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director3818640003
    MARX, Michael Henry
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Administrateur
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant35019090001
    PROTHERO, Graham
    Bracken Lane
    RH20 3HR Storrington
    Three Gables
    West Sussex
    England
    Administrateur
    Bracken Lane
    RH20 3HR Storrington
    Three Gables
    West Sussex
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant134427450001
    HACKWOOD DIRECTORS LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Administrateur désigné
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004840001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00701787
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 16 déc. 2011
    Livré le 22 déc. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and property k/a 131 broadway bexleyheath t/no. SGL519434 by way of fixed charge all rights and interest in the rental income goodwill and the proceeds of insurances by way of floating charge all right and interest in all plant and equipment located in the property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Agent and Security Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transactions
    • 22 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 16 déc. 2011
    Livré le 22 déc. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of properties charged please refer to form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Agent and Security Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transactions
    • 22 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 01 févr. 2008
    Livré le 08 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a 131 broadway, bexleyheath t/no SGL519434. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 15 août 2005
    Livré le 17 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from development securities PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of f/h property k/a 131 the broadway bexleyheath kent t/no SGL519434.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 17 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental deed (being supplemental to a deed of legal charge dated 23 december 1998)
    Créé le 11 juil. 2005
    Livré le 29 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from development securities estates PLC and development securities (strategic) LTD to the chargee under the terms of the aformentioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 131 the broadway bexleyheath kent t/n SGL519434 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 29 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of release and charge
    Créé le 11 avr. 1997
    Acquis le 08 avr. 2003
    Livré le 17 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £20,000,000 11% first mortgage debenture stock 2016 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    131 broadway bexleyheath t/n SGL519434 held jointly with development securities (no.7) limited.
    Personnes ayant droit
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transactions
    • 17 avr. 2003Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 24 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0