EVER 1824 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEVER 1824 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04460079
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EVER 1824 LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe EVER 1824 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de EVER 1824 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour EVER 1824 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 mars 2017

    8 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor Clarence House Clarence Street Manchester M2 4DW à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 14 avr. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 mars 2016

    LRESSP

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juin 2015

    État du capital au 16 juin 2015

    • Capital: GBP 4
    SH01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    DISS40

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    14 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juin 2014

    État du capital au 27 juin 2014

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Cessation de la nomination de Simon Bate en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * the Pinnacle 5Th Floor 73 - 79 King Street Manchester M2 4NG England* le 27 juin 2014

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Kenneth Knott en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Parker en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Burkinshaw en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Burke en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * the Old School House George Leigh Street Manchester M4 6AF* le 08 déc. 2011

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de EVER 1824 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CROSS, Jonathan Paul
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    Secrétaire
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    British145992930001
    CROSS, Jonathan Paul
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    Administrateur
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    United KingdomBritish145991240001
    HUGHES, John James
    2 Bamford Road
    M20 2GW Didsbury
    Ivy Bank
    Administrateur
    2 Bamford Road
    M20 2GW Didsbury
    Ivy Bank
    EnglandBritish125765810001
    BATE, Simon Donald
    24 Park Road
    WA15 9NN Altrincham
    Secrétaire
    24 Park Road
    WA15 9NN Altrincham
    British75874130004
    COUGHLAN, Monica
    Newlands
    Station Road
    SK6 6PA Marple
    Cheshire
    Secrétaire
    Newlands
    Station Road
    SK6 6PA Marple
    Cheshire
    British106801230001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secrétaire désigné
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    ARMSTEAD, Michael Brian
    West House Fiveways
    1 Gorsey Lane
    WA14 4BN Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    West House Fiveways
    1 Gorsey Lane
    WA14 4BN Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish57228500002
    BATE, Simon Donald
    20 East Downs Road
    WA14 2LQ Bowdon
    Paddock House
    Cheshire
    Administrateur
    20 East Downs Road
    WA14 2LQ Bowdon
    Paddock House
    Cheshire
    United KingdomBritish140715780001
    BURKE, Alan Francis
    Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    2
    Cheshire
    Administrateur
    Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    2
    Cheshire
    EnglandBritish182234260001
    BURKINSHAW, David
    Carlton Road
    Urmston
    M41 9GY Manchester
    12
    Administrateur
    Carlton Road
    Urmston
    M41 9GY Manchester
    12
    EnglandBritish149306770001
    DODD, Andrew Gerard
    Court Essington
    Midford
    BA2 7BX Bath
    Administrateur
    Court Essington
    Midford
    BA2 7BX Bath
    United KingdomBritish74768570020
    HENDERSON, Alexander Scott
    The Lilacs
    29 Bower Road Hale
    WA15 9DR Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    The Lilacs
    29 Bower Road Hale
    WA15 9DR Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish115112930001
    KNOTT, Kenneth John
    Etherow Country Park
    Compstall
    SK6 5JQ Stockport
    Foxes Lair
    Cheshire
    Administrateur
    Etherow Country Park
    Compstall
    SK6 5JQ Stockport
    Foxes Lair
    Cheshire
    United KingdomBritish101368570002
    PARKER, Andrew
    Nunnery Way
    Clifford
    LS23 6SL Wetherby
    12
    West Yorkshire
    Administrateur
    Nunnery Way
    Clifford
    LS23 6SL Wetherby
    12
    West Yorkshire
    UkBritish146469710001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Administrateur désigné
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    EVER 1824 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 oct. 2009
    Livré le 09 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligor and each other member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H land and buildings at leopold street sheffield and hotel at leopold street sheffield t/nos syk 508127 and syk 508128. l/h 4A leopold square t/n syk 536745. l/h the old school house, george leigh street, manchester and fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2006
    Livré le 29 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The land and buildings k/a the multi screen cinema and public house clippers quay salford l/h t/no GM824520, the land and buildings k/a the land on the west side of trafford road clippers quay salford l/h t/no GM744333, the land and buildings k/a the pump house trafford road salford l/h t/no GM588084. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Co-Operative Bank P.L.C. as Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 29 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 juin 2003
    Livré le 02 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The land on the south west side og clipper quay trafford road t/n GM474905. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 02 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 févr. 2003
    Livré le 11 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 févr. 2003
    Livré le 11 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a multi-screen cinema and public house at clippers quay salford quays t/n gm 824520. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    EVER 1824 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 mars 2016Commencement of winding up
    31 août 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0